A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামA.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 01192394
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উত্পাদন (27900) / উৎপাদন

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Staverton Court
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    18 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১১ জুল, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    15 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১১ জুল, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠাLIQ03

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    20 পৃষ্ঠাAM22

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    18 পৃষ্ঠাAM10

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    5 পৃষ্ঠাAM07

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    31 পৃষ্ঠাAM03

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ AM02SOA

    8 পৃষ্ঠাAM02

    ১১ আগ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Querns Business Centre Whitworth Road Cirencester Glos GL7 1RT থেকে Staverton Court Staverton Cheltenham Gloucestershire GL51 0UXপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAM01

    ২৬ জুল, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Ross Mactaggart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    5 পৃষ্ঠাMR04

    ১৯ জুন, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Boyd Mccollum এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ১০ আগ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ আগ, ২০১৫

    ১৯ আগ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 237,438
    SH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    ০৮ আগ, ২০১৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 237,438
    4 পৃষ্ঠাSH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ সেপ, ২০১৪

    ০২ সেপ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 237,438
    SH01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ আগ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ এপ্রি, ২০১৪

    ১৫ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 236,070
    SH01

    ০২ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত রসিদ এবং অর্থপ্রদানের স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সুপারভাইজারের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা1.3

    স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সমাপ্তির নোটিশ

    11 পৃষ্ঠা1.4

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MACTAGGART, Neil Ross
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Gloucestershire
    সচিব
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant56446510001
    GILCHRIEST, Peter John
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director12778960001
    GILCHRIEST, Peter John
    Stable Cottage
    Chedglow Crudwell
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wilts
    সচিব
    Stable Cottage
    Chedglow Crudwell
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wilts
    BritishDirector12778960001
    WILLIS, John Andrew
    8 The Butts
    Crudwell
    SN16 9HF Malmesbury
    Wiltshire
    সচিব
    8 The Butts
    Crudwell
    SN16 9HF Malmesbury
    Wiltshire
    British12778930001
    BATTILORO, John Roberts
    237 Albemarle Road
    White Plains
    New York
    10605
    Usa
    পরিচালক
    237 Albemarle Road
    White Plains
    New York
    10605
    Usa
    AmericanCompany Director84272710001
    FLETCHER, Leslie Ronald
    38 Alexander Drive
    GL7 1UG Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    38 Alexander Drive
    GL7 1UG Cirencester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director12778940001
    FOOTER, Michael Charles
    Wychwood Place
    SO22 6BE Winchester
    2
    Hampshire
    পরিচালক
    Wychwood Place
    SO22 6BE Winchester
    2
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director147959810001
    HAMMOND, Michael
    Nation House
    3 George Street, Bisley
    GL6 7BB Stroud
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Nation House
    3 George Street, Bisley
    GL6 7BB Stroud
    Gloucestershire
    BritishSales Director89464040001
    MACTAGGART, Neil Ross
    Querns Business Centre
    Whitworth Road
    GL7 1RT Cirencester
    Glos
    পরিচালক
    Querns Business Centre
    Whitworth Road
    GL7 1RT Cirencester
    Glos
    EnglandBritishChartered Accountant56446510001
    MCCOLLUM, Kevin Boyd
    Waterton Lane
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Waterton Stables
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Waterton Lane
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Waterton Stables
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director121972580001
    ROBERTS, David Fredrick
    Dryhill House The Heavens
    Lypiatt
    GL6 7LT Stroud
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Dryhill House The Heavens
    Lypiatt
    GL6 7LT Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director58151590001
    TAYLOR, Edward
    2 Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    Bucks
    পরিচালক
    2 Deep Acres
    HP6 5NX Amersham
    Bucks
    Great BritainBritishCompany Director32403790002
    WATTS, Colin Richard
    7 Richards Close
    SN4 7LE Wootton Bassett
    Wiltshire
    পরিচালক
    7 Richards Close
    SN4 7LE Wootton Bassett
    Wiltshire
    United KingdomBritishMarketing Director83365280001
    WILLIS, John Andrew
    8 The Butts
    Crudwell
    SN16 9HF Malmesbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    8 The Butts
    Crudwell
    SN16 9HF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director12778930001
    WOODSEND, Hugh Gervase
    Little Hill Farmhouse
    OX7 6LF Milton Under Wychwood
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Little Hill Farmhouse
    OX7 6LF Milton Under Wychwood
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director91499940001

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Mr John Arthur Hugh Curry
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Gloucestershire
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Gloucestershire
    না
    জাতীয়তা: British
    বাসস্থানের দেশ: England
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ২৫% এর বেশি কিন্তু ৫০% এর বেশি নয় শেয়ারের মালিকানাধীন।

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০১৪
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Peter Gilchriest
    • Monmouth LTD
    • Kevin Mccollum
    • John Curry
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a fixed charge and legal mortgage all f/h and l/h property now owned by the chargor. By way of fixed charge all the fixed plant machinery and fixtures (including trade fixtures) in, on or attached to any property, all goodwill, all unpaid and/or uncalled capital, all debts both present and future and all other debts; by way of floating charge all the undertaking and all its property, assets, rights, title and interest both present and future. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৭ জুল, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All plant, equipment, furniture, fixtures and fitting, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Curry, Kevin Mccollum, Monmouth LTD
    ব্যবসায়
    • ২২ সেপ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১২ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All plant,equipment,furniture fixtures and fittings,all stocks of components and finished products see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Curry,Kevin Mccollum and Monmouth Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ সেপ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০১ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £3,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal charge the deposited sum. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ambas Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ডিসে, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or A.R.G. marine limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    A.R.G. ELECTRODESIGN LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০২ এপ্রি, ২০১৪সিভিএ সম্পন্ন বা সমাপ্তির তারিখ
    ০৮ এপ্রি, ২০১১সিভিএ অনুমোদনের সভার তারিখ
    কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা (সিভিএ)
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Philip John Gorman
    Hazlewoods
    Windsor House
    Barnett Way
    Barnwood Gloucester
    অভ্যাসকারী
    Hazlewoods
    Windsor House
    Barnett Way
    Barnwood Gloucester
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৬ জুল, ২০১৭প্রশাসন শুরু
    ১২ জুল, ২০১৮প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Victor Henry Ellaby
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    অভ্যাসকারী
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Peter Richard James Frost
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    অভ্যাসকারী
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    3
    তারিখপ্রকার
    ১১ ডিসে, ২০২১ভেঙে গেছে
    ১২ জুল, ২০১৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Peter Richard James Frost
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    অভ্যাসকারী
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    Victor Henry Ellaby
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    অভ্যাসকারী
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Peter Richard James Frost
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    অভ্যাসকারী
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    Victor Henry Ellaby
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    অভ্যাসকারী
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0