TN RECRUITMENT LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTN RECRUITMENT LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05183160
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TN RECRUITMENT LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9305) /

    TN RECRUITMENT LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o KEVIN BROWN ADVISORY LIMITED
    500 High Road
    IG8 0PN Woodford Green
    Essex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TN RECRUITMENT LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MEDIPLACEMENTS LIMITED২০ ডিসে, ২০০৪২০ ডিসে, ২০০৪
    SPEED 9908 LIMITED১৯ জুল, ২০০৪১৯ জুল, ২০০৪

    TN RECRUITMENT LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    TN RECRUITMENT LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    21 পৃষ্ঠাLIQ14

    ২৯ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    17 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৯ জানু, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68

    ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 7 Johnston Road Woodford Green IG8 0XB থেকে C/O Kevin Brown Advisory Limited 500 High Road Woodford Green Essex IG8 0PNপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৯ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠা4.68

    ২৯ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68

    ২৯ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ৩০ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটরের অপসারণের সার্টিফিকেট

    1 পৃষ্ঠা4.38

    ২০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠা4.68

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাF10.2

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    3 পৃষ্ঠা4.20

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    17 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন

    LRESEX

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed mediplacements LIMITED\certificate issued on 17/06/11
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১৭ জুন, ২০১১

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৬ জুন, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ সেপ, ২০১০

    ৩০ সেপ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 9,900
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share fot share exchange 01/06/2010
    RES13

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    24 পৃষ্ঠাAA

    TN RECRUITMENT LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PORTER, Steven
    6 Waverley Gardens
    IG6 1PJ Ilford
    Essex
    সচিব
    6 Waverley Gardens
    IG6 1PJ Ilford
    Essex
    British117397040001
    SIMPSON, Edward Clive
    St. Michaels House
    Amies Green
    EN9 2AU Waltham Abbey
    Essex
    পরিচালক
    St. Michaels House
    Amies Green
    EN9 2AU Waltham Abbey
    Essex
    EnglandBritish142572880001
    SIMPSON, Clive Reginald
    St Michaels House
    Aimes Green, Galley Hill
    EN9 2AU Waltham Abbey
    Essex
    সচিব
    St Michaels House
    Aimes Green, Galley Hill
    EN9 2AU Waltham Abbey
    Essex
    British96038390001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    DOBRYNIEWSKI, Tomasz Rajmund
    30 Sezamkowa
    Wroclaw
    Apt 5 4,
    52-317-5
    Poland
    পরিচালক
    30 Sezamkowa
    Wroclaw
    Apt 5 4,
    52-317-5
    Poland
    Polish134850040001
    MANDZIOU, Ewa
    Stefana Wyszyriskiego Street
    100 Kard
    Apt 4,
    Wroclaw
    Poland
    পরিচালক
    Stefana Wyszyriskiego Street
    100 Kard
    Apt 4,
    Wroclaw
    Poland
    Polish134849630001
    MISIAK, Tomasz
    Ul. Marii Curie-Sklodowskiej 49/12
    Wroclaw
    Poland
    পরিচালক
    Ul. Marii Curie-Sklodowskiej 49/12
    Wroclaw
    Poland
    Polish125656860001
    PAWLAK, Konrad
    Zernicka St 241
    54-510 Wroclaw
    Poland
    পরিচালক
    Zernicka St 241
    54-510 Wroclaw
    Poland
    Polish125656870001
    SIMPSON, Clive Reginald
    St Michaels House
    Aimes Green, Galley Hill
    EN9 2AU Waltham Abbey
    Essex
    পরিচালক
    St Michaels House
    Aimes Green, Galley Hill
    EN9 2AU Waltham Abbey
    Essex
    EnglandBritish96038390001
    SZPIKOWSKI, Tomasz
    Ul. Sezamkowa 16/4
    52-314 Wroclaw
    Poland
    পরিচালক
    Ul. Sezamkowa 16/4
    52-314 Wroclaw
    Poland
    Polish130446060001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    TN RECRUITMENT LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Edward Clive Simpson
    ব্যবসায়
    • ২২ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Charge of shares
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as speed 9908 limited) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    9,900 ordinary shares of £1 each in medi-placements limited all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as speed 9908 limited) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the charter house charter mews ilford essex t/no: EGL46024. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as speed 9908 limited) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplement to debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (formerly known as speed 9908 limited) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company's right title and interest in and to a share purchase agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as speed 9908 limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    TN RECRUITMENT LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২১ সেপ, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৬ ফেব, ২০১৯ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    অভ্যাসকারী
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Kevin Thomas Brown
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London
    অভ্যাসকারী
    10 John Princes Street
    W1G 0AH London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0