EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00932138 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED?
- Sonstige unterstützende Tätigkeiten im Verkehr (52290) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | PO BOX 8663 Ceva House Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Leicestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EAGLE INTERNATIONAL (UK) LIMITED | 01. Juli 1998 | 01. Juli 1998 |
| S.BOARDMAN (AIR SERVICES) LIMITED | 16. Mai 1968 | 16. Mai 1968 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Ms Tracy Amanda Moore als Sekretär am 27. Juli 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr David Alun Jones als Direktor am 20. Juli 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von James Edward Gill als Geschäftsführer am 21. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Dawn Amanda Wetherall als Sekretär am 22. Juli 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Christopher Gareth Walton als Direktor am 10. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Edward Aston als Geschäftsführer am 07. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Leigh Martin Pomlett als Geschäftsführer am 06. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr James Edward Gill als Direktor am 03. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 009321380017 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 009321380011 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 009321380016 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 009321380015 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 009321380014 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 009321380013 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Tracy Amanda | Sekretär | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | 272627610001 | |||||||
| JONES, David Alun | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | England | British | 272304810001 | |||||
| WALTON, Christopher Gareth | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | England | British | 267176260001 | |||||
| BIRD, Anthony Michael | Sekretär | 58 Squires Bridge Road TW17 0QA Shepperton Middlesex | British | 99594340001 | ||||||
| BORGES, Yamila | Sekretär | 56 Cranston Close TW3 3DQ Hounslow Middlesex | Venezuelan | 84577970007 | ||||||
| GARRAWAY, Wendy Anne | Sekretär | Warren Lane Bythorn PE28 0QU Huntingdon Hayrick House Cambridgeshire | British | 128067090001 | ||||||
| HERREID, Steven Michael | Sekretär | Brookside Ascot Road, Holyport SL6 2HY Maidenhead Berkshire | American | 55844500002 | ||||||
| JUDGE, Paul Thomas | Sekretär | 6 Catcliffe Way Lower Earley RG6 4HX Reading Berkshire | British | 6531060001 | ||||||
| MCDONNELL, Martin | Sekretär | 13271 Overlook Court Conroe Texas 77302 Usa | Us Citizen | 105260000001 | ||||||
| NICHOLS, Rupert Henry Conquest | Sekretär | Ceva House Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch PO BOX 8663 Leicestershire | British | 130340470001 | ||||||
| RYAN, Gerard | Sekretär | 3 Madingley Court Willoughby Road TW1 2QN Twickenham Middlesex | Irish | 120580170001 | ||||||
| WETHERALL, Dawn Amanda | Sekretär | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | 147893280001 | |||||||
| ASTON, Edward | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | England | British | 243581330001 | |||||
| BARTLETT, Philip George | Geschäftsführer | 11 Dukes Ride SL9 7LE Gerrards Cross Bucks | British | 21982060001 | ||||||
| BATEMAN, Roy | Geschäftsführer | 49 Avon Road TW16 7SZ Sunbury On Thames Middlesex | British | 43254140001 | ||||||
| BIRD, Anthony Michael | Geschäftsführer | 58 Squires Bridge Road TW17 0QA Shepperton Middlesex | England | British | 99594340001 | |||||
| BORGES, Yamila | Geschäftsführer | 56 Cranston Close TW3 3DQ Hounslow Middlesex | Venezuelan | 84577970007 | ||||||
| CANTRELL, David Walter | Geschäftsführer | 14 Maidenhead Road SL4 5EQ Windsor Berkshire | British | 6531070001 | ||||||
| CARATTINI, Stephen Joseph | Geschäftsführer | 39 Lavender Haze Place The Woodlands 77381 Houston Texas United States Of America | American | 59127500001 | ||||||
| CHARLES, Richard Trevor | Geschäftsführer | 49 Carnation Drive Winkfield Row RG42 7NT Bracknell Berkshire | British | 68368440001 | ||||||
| COONEY, Patrick John | Geschäftsführer | Lancaster House 137 Fairmile Lane KT11 2BU Cobham Surrey | American | 91719240002 | ||||||
| CORPE, Geoffrey Leonard | Geschäftsführer | London Road TW18 4BP Staines 18-32 Middlesex | British | 86762200001 | ||||||
| DEGNAN, Ian Alan | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | England | English | 172889330001 | |||||
| FAVATI, Vittorio | Geschäftsführer | 90 Batesbrooke Court 77381 The Woodlands Texas Usa | American | 66964040001 | ||||||
| GILL, James Edward | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | England | British | 165998750001 | |||||
| HERREID, Steven Michael | Geschäftsführer | Brookside Ascot Road, Holyport SL6 2HY Maidenhead Berkshire | American | 55844500002 | ||||||
| JACKSON, Martin | Geschäftsführer | 6 Tamarisk Rise RG40 1WG Wokingham Berkshire | England | British | 101348910001 | |||||
| JUDGE, Paul Thomas | Geschäftsführer | 6 Catcliffe Way Lower Earley RG6 4HX Reading Berkshire | British | 6531060001 | ||||||
| KEITH, Winters | Geschäftsführer | Bontiuslaan 1a Wassenaar 2242 Pw Netherlands | American | 107699640001 | ||||||
| KENNA, Declan | Geschäftsführer | 28 Ennismore Avenue Flat 3 Chiswick W4 1SF London | Irish | 86425040001 | ||||||
| KING, Stephen Roy | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | United Kingdom | British | 155425340001 | |||||
| KING, Stephen Roy | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 1NU Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | United Kingdom | British | 155425340001 | |||||
| LEONARD, Charles H | Geschäftsführer | 3022 Tangley Houston Texas 77005 U.S.A. | Usa | 117834620001 | ||||||
| MCDONNELL, Martin | Geschäftsführer | 13271 Overlook Court Conroe Texas 77302 Usa | Us Citizen | 105260000001 | ||||||
| MCDOUGAL, Rubin J | Geschäftsführer | Excelsior Road LE65 9BA Ashby De La Zouch Ceva House Leicestershire | Netherlands | American | 151516540001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceva Freight (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Excelsior Road 8663 LE65 9BA Ashby-De-La-Zouch Ceva House Leicestershire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EAGLE GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 19. März 2018 Geliefert am 22. März 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 07. Apr. 2017 Geliefert am 11. Apr. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 19. März 2014 Geliefert am 27. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 19. März 2014 Geliefert am 27. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 19. März 2014 Geliefert am 27. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. Juli 2013 Geliefert am 25. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 02. Mai 2013 Geliefert am 13. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 02. Mai 2013 Geliefert am 13. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 01. Feb. 2012 Geliefert am 09. Feb. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 14. Dez. 2010 Geliefert am 31. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 24. März 2010 Geliefert am 06. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 06. Okt. 2009 Geliefert am 21. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second lien fixed and floating security document | Erstellt am 22. Juli 2009 Geliefert am 03. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second lien fixed and floating security document | Erstellt am 13. Aug. 2007 Geliefert am 31. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Its obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all amterial real property by way of fixed equitable charge all other real property by way of fixed charge all its present and future book debts bank accounts investments uncalled capital goodwill intellectual property plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 02. Aug. 2007 Geliefert am 21. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers and any of the subsidiaries to the lender or any of its affiliates under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Syndicated composite guarantee and debenture between the company, F.J. tytherleigh & co. Limited and egl eagle global logistics (UK) limited (together the "chargors" each a "chargor") and the chargee (the "security trustee") | Erstellt am 09. Nov. 2001 Geliefert am 26. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities on the part of egl, inc., A texas corporation (the "borrower") and/or each chargor to the chargee as security trustee or any other beneficiary, under or pursuant to the terms of the agreement, the debenture or under any of the other loan documents and/or in connection with the loan facility or other financial accomodation. | |
Kurze Angaben By way of equitable mortgage its property. By way of specific charge its equipment and inventory, investments, debts, intellectual property, licenses, deeds, documents, goodwill, policies, compensation monies, covenants, all proceeds of a capital nature, all rights and claims against all lessees, contracts, agreements or licenses. By way of a floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. Assignment by way of security all its rights, title and interest in and to the policies and debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 10. Aug. 1989 Geliefert am 30. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re: s boardman (air services) LTD. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0