CHARNWOOD FOODS LIMITED: Geschäftsführer

  • Überblick

    UnternehmensnameCHARNWOOD FOODS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01205129
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Wer sind die Geschäftsführer von CHARNWOOD FOODS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Sekretär
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Sekretär
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Geschäftsführer
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Geschäftsführer
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Geschäftsführer
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    GRANT, Brian John
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish64875090001
    HARGREAVES, Stephen John
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Great BritainBritish99437380001
    HODSON, Mark Anthony
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    EnglandBritish142364940001
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Geschäftsführer
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124625030001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Geschäftsführer
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    PICKERING, Alistair Neil
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    Geschäftsführer
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    United KingdomBritish83785410002
    QUICK, Nigel Robert
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    British36629900001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish42065200002
    SIMMONS, Alex Thomas
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish105865430001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish147725160001
    SWEENEY, Brendan John
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    Geschäftsführer
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    British Irish79007350001
    WHITING, Timothy James
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    British44028500002
    WIGNALL, Howard Ernest Edwin
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    British32234150001

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0