LAWRIE EASTON IMPORTS LIMITED: Geschäftsführer

  • Überblick

    UnternehmensnameLAWRIE EASTON IMPORTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01655607
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Wer sind die Geschäftsführer von LAWRIE EASTON IMPORTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Sekretär
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    155916890001
    TAYLOR, Laura
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northants
    United Kingdom
    United KingdomBritish155913200001
    WILSON, Charles
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    Geschäftsführer
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northants
    United KingdomBritish123998480001
    ATTWOOD, Paul Gerard
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    Sekretär
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    British72538660001
    BELTON, Doris Valerie
    49 Drayton Road
    Irthlingborough
    NN9 5TA Wellingborough
    Northamptonshire
    Sekretär
    49 Drayton Road
    Irthlingborough
    NN9 5TA Wellingborough
    Northamptonshire
    British67694030001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    Sekretär
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    British78255980001
    CHILTON, Mark
    9 Oakwood
    NE46 4LF Hexham
    Northumberland
    Sekretär
    9 Oakwood
    NE46 4LF Hexham
    Northumberland
    British109675640001
    DAWSON, Jeffrey George
    14b Clare Street
    PE16 6EJ Chatteris
    Cambridgeshire
    Sekretär
    14b Clare Street
    PE16 6EJ Chatteris
    Cambridgeshire
    British4976790001
    JOHNSON, Shirley Elizabeth
    25 Stoney Common
    CM24 8NF Stansted
    Essex
    Sekretär
    25 Stoney Common
    CM24 8NF Stansted
    Essex
    British52701320001
    LAMB, Robin Graham Belhaven
    1 Hertford Lodge
    20 Albert Drive
    SW19 6NE London
    Sekretär
    1 Hertford Lodge
    20 Albert Drive
    SW19 6NE London
    British113735290001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Sekretär
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    British48949090001
    BUSBY, Adrian John
    22 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    22 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British3445300001
    CAMP, Michael James
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Heath Cottage
    Marriotts Avenue, South Heath
    HP16 9QW Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish12204760003
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    DYE, Simon John
    46 Albany Road
    NN1 5LZ Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    46 Albany Road
    NN1 5LZ Northampton
    Northamptonshire
    British67908930001
    EASTON, Lawrence Harold
    638 Princes Road
    DA2 6JQ Dartford
    Kent
    Geschäftsführer
    638 Princes Road
    DA2 6JQ Dartford
    Kent
    British27035700001
    FLEXEN, John Michael
    Ochre Cottage
    Church Lane Wroxton
    OX15 6QT Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Ochre Cottage
    Church Lane Wroxton
    OX15 6QT Banbury
    Oxfordshire
    British984380003
    HALL, Hugh Nigel
    Highfield The Rise
    East Horsley
    KT24 5BJ Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Highfield The Rise
    East Horsley
    KT24 5BJ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish50999730001
    HOPKINS, Antony Dudley
    2 Parsons Mead
    KT8 9DT East Molesey
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Parsons Mead
    KT8 9DT East Molesey
    Surrey
    British5863900001
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Geschäftsführer
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    KERRY, Norman Ernest
    Le Patela
    Southlands Grove
    BR1 2DQ Bickley
    Kent
    Geschäftsführer
    Le Patela
    Southlands Grove
    BR1 2DQ Bickley
    Kent
    EnglandBritish10218430001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    United KingdomBritish48949090001
    RENTOUL, James Alexander
    1a Dartmouth Place
    W4 2RH London
    Geschäftsführer
    1a Dartmouth Place
    W4 2RH London
    British58897290002
    RUSSELL, Michael John
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Holly Cottage
    The Old Orchard Calcot
    RG31 7RF Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish48183050001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish52926050001

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0