BELMONT OPTICAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BELMONT OPTICAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01961218 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BELMONT OPTICAL LIMITED?
- Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 47 Joel Lane SK14 5JZ Hyde England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PENNINE OPTICAL GROUP LIMITED | 27. Feb. 1995 | 27. Feb. 1995 |
| PENNINE OPTICAL LIMITED | 15. Jan. 1990 | 15. Jan. 1990 |
| SOVEREIGN OPTICAL LIMITED | 19. Nov. 1985 | 19. Nov. 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 21 Brackley Street Farnworth Bolton BL4 9DS England zum 47 Joel Lane Hyde SK14 5JZ am 23. Okt. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 9 Seiten | MA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Clyde Haydn Williams als Sekretär am 03. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Lawrence Cowan als Geschäftsführer am 03. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Clyde Haydn Williams als Geschäftsführer am 03. Apr. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Anthony Newton als Direktor am 03. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Manchester Road Heaton Norris Stockport SK4 1TX zum 21 Brackley Street Farnworth Bolton BL4 9DS am 22. Nov. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Clyde Haydn Williams als Direktor am 13. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Lawrence Cowan am 10. Feb. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON, Philip Anthony | Geschäftsführer | Joel Lane SK14 5JZ Hyde 47 England | United Kingdom | British | 250974400001 | |||||
| HIGHAM, Maria Gabrielle | Sekretär | Eastcote 25 Delahays Road WA15 8DS Hale Cheshire | British | 56630460001 | ||||||
| HORNBY, Alan | Sekretär | 58 Garners Lane Davenport SK3 8QT Stockport Cheshire | British | 96367080001 | ||||||
| O'SULLIVAN, John | Sekretär | 1 Manchester Road Heaton Norris SK4 1TX Stockport | 155663970001 | |||||||
| VICARY, Gary Kevin | Sekretär | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| WILLIAMS, Simon Clyde Haydn | Sekretär | Brackley Street Farnworth BL4 9DS Bolton 21 England | 176154070001 | |||||||
| COWAN, Peter Lawrence | Geschäftsführer | Brackley Street Farnworth BL4 9DS Bolton 21 England | England | British | 141897770003 | |||||
| ELDRIDGE, Malcolm James Eldridge | Geschäftsführer | Stanton 6 Lukes Yeat St Neot PL14 6NG Liskeard Cornwall | British | 54219730001 | ||||||
| HIGHAM, Maria Gabrielle | Geschäftsführer | Eastcote 25 Delahays Road WA15 8DS Hale Cheshire | British | 56630460001 | ||||||
| HILLMAN, Peter John | Geschäftsführer | 62 Micawber Way Newlands Spring CM1 4UE Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 86069010001 | |||||
| HORNBY, Alan | Geschäftsführer | 58 Garners Lane Davenport SK3 8QT Stockport Cheshire | England | British | 96367080001 | |||||
| LEHMANN, Frederick Allan | Geschäftsführer | 5 Chartridge Close Arkley EN5 3LX Barnet Hertfordshire | British | 75525310001 | ||||||
| NIGHTINGALE, Bernard | Geschäftsführer | 976 Warwick Road Copt Heath B91 3HN Solihull West Midlands | British | 2994970001 | ||||||
| NIGHTINGALE, Charles | Geschäftsführer | 34 Carpenter Road Edgbaston B15 2JH Birmingham West Midlands | British | 5183860003 | ||||||
| PERERA, David | Geschäftsführer | 6 The Grange 36 Edgeley Road SK3 9NQ Stockport Cheshire | England | British | 127795280001 | |||||
| PERERA, Kenneth | Geschäftsführer | West View Peak Forest SK17 8EW Buxton Derbyshire | British | 30140880001 | ||||||
| PLUMMER, Alan | Geschäftsführer | 3 Hillbrook Road Bramhall SK7 2BT Stockport Cheshire | British | 3215730001 | ||||||
| TAYLOR, Desmond Francis | Geschäftsführer | 9 Florence Close CV9 1HR Atherstone Warwickshire | British | 38196160001 | ||||||
| VICARY, Gary Kevin | Geschäftsführer | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| WILLIAMS, Simon Clyde Haydn | Geschäftsführer | Brackley Street Farnworth BL4 9DS Bolton 21 England | England | English | 256296590001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BELMONT OPTICAL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Peter Lawrence Cowan | 06. Apr. 2016 | Joel Lane SK14 5JZ Hyde 47 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat BELMONT OPTICAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a navigation mill manchester road heaton norris stockport t/no: GM319249. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Nov. 1999 Geliefert am 15. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 21. Dez. 1998 Geliefert am 23. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Aug. 1995 Geliefert am 15. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or united optical industries limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H pennine house manchester road stockport t/no.GM319249 and all buildings and other structures and goodwill. Fixed and floating charges over all plant machinery and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Aug. 1995 Geliefert am 12. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. Juli 1990 Geliefert am 26. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 1987 Geliefert am 05. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 133 starkey street heywood lancs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Juni 1986 Geliefert am 10. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0