HANSON BUILDING PRODUCTS (2003) LIMITED: Geschäftsführer

  • Überblick

    UnternehmensnameHANSON BUILDING PRODUCTS (2003) LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02448833
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Wer sind die Geschäftsführer von HANSON BUILDING PRODUCTS (2003) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROGERS, Wendy Fiona
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    Sekretär
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    206031890001
    BENNING-PRINCE, Nicholas Arthur Dawe, Mr.
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    EnglandBritish182670630001
    DOWLEY, Robert Charles
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    EnglandBritish183842720001
    GRETTON, Edward Alexander
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    EnglandBritish130888540002
    QUILEZ SOMOLINOS, Alfredo
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Lane
    SL6 8QZ Maidenhead
    Second Floor, Arena Court
    Berkshire
    England
    EnglandSpanish287317590001
    DOUGAL, Andrew James Harrower
    10
    Westerdale Drive Frimley
    GU16 5RB Camberley
    Surrey
    Sekretär
    10
    Westerdale Drive Frimley
    GU16 5RB Camberley
    Surrey
    British42737230001
    DRANSFIELD, Graham
    Downs Hill
    BR3 5HB Beckenham
    18
    Kent
    Sekretär
    Downs Hill
    BR3 5HB Beckenham
    18
    Kent
    British4655640001
    FERNLEY, Simon Roger
    The Coach House
    Manor Drive Bathford
    BA1 7TY Bath
    Sekretär
    The Coach House
    Manor Drive Bathford
    BA1 7TY Bath
    British33922880002
    PETERS, Ian Alan Duncan
    Rectory Stables
    Gay Street
    BA11 3PT Mells
    Somerset
    Sekretär
    Rectory Stables
    Gay Street
    BA11 3PT Mells
    Somerset
    British154498310001
    TUNNACLIFFE, Paul Derek
    6 Ashburnham Park
    KT10 9TW Esher
    Surrey
    Sekretär
    6 Ashburnham Park
    KT10 9TW Esher
    Surrey
    British127202460001
    TYLER, Ian Paul
    Lime Tree House
    3b Village Road, Cockayne Hatley
    SG19 2EE Sandy
    Bedfordshire
    Sekretär
    Lime Tree House
    3b Village Road, Cockayne Hatley
    SG19 2EE Sandy
    Bedfordshire
    British66794160001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    Sekretär
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    British113777700001
    VARCOE, Richard Antony Bruce, Dr
    105 Thingwall Park
    Fishponds
    BS16 2AR Bristol
    Sekretär
    105 Thingwall Park
    Fishponds
    BS16 2AR Bristol
    British55610930001
    VIVIAN, Simon Neil
    Pond Farm Cottage
    Faulkland
    BA3 5YG Bath
    Somerset
    Sekretär
    Pond Farm Cottage
    Faulkland
    BA3 5YG Bath
    Somerset
    British97479630001
    BOLTER, Andrew Christopher
    110 North View Road
    Crouch End
    N8 7LP London
    Geschäftsführer
    110 North View Road
    Crouch End
    N8 7LP London
    British90294620001
    CLARKE, David Jonathan
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish160732500001
    COTTON, Anthony Ross
    Apartment 2403 The York
    5 York Street
    Sydney
    Nsw 2000
    Australia
    Geschäftsführer
    Apartment 2403 The York
    5 York Street
    Sydney
    Nsw 2000
    Australia
    British809750001
    COULSON, Ruth
    Flat 4
    14 Steeles Road
    NW3 4SE London
    Geschäftsführer
    Flat 4
    14 Steeles Road
    NW3 4SE London
    Australian109716390001
    DOUGAL, Andrew James Harrower
    10
    Westerdale Drive Frimley
    GU16 5RB Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    10
    Westerdale Drive Frimley
    GU16 5RB Camberley
    Surrey
    British42737230001
    DRANSFIELD, Graham
    Downs Hill
    BR3 5HB Beckenham
    18
    Kent
    Geschäftsführer
    Downs Hill
    BR3 5HB Beckenham
    18
    Kent
    EnglandBritish4655640001
    EGAN, David John
    Valley Road
    WD3 4BJ Rickmansworth
    70
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Valley Road
    WD3 4BJ Rickmansworth
    70
    Hertfordshire
    United KingdomBritish324778100001
    FERNLEY, Simon Roger
    The Coach House
    Manor Drive Bathford
    BA1 7TY Bath
    Geschäftsführer
    The Coach House
    Manor Drive Bathford
    BA1 7TY Bath
    EnglandBritish33922880002
    GIMMLER, Richard Robert
    Church Walk
    Ashton Keynes
    SN6 6PB Swindon
    Glebe House
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Church Walk
    Ashton Keynes
    SN6 6PB Swindon
    Glebe House
    Wiltshire
    EnglandBritish131676390004
    GUYATT, Benjamin John
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    Geschäftsführer
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    United KingdomBritish131516210001
    LECLERCQ, Christian
    Court Drive
    SL6 8LX Maidenhead
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Court Drive
    SL6 8LX Maidenhead
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBelgian130757120001
    MEINS, John Charles
    31 Butler's Court Road
    HP9 1SQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    31 Butler's Court Road
    HP9 1SQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59558870001
    MENZIES-GOW, Robert Ian
    Ashwell Cottage Church Close
    Ashwell
    LE15 7LP Oakham
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Ashwell Cottage Church Close
    Ashwell
    LE15 7LP Oakham
    Leicestershire
    United KingdomBritish75693480001
    PETERS, Ian Alan Duncan
    Rectory Stables
    Gay Street
    BA11 3PT Mells
    Somerset
    Geschäftsführer
    Rectory Stables
    Gay Street
    BA11 3PT Mells
    Somerset
    EnglandBritish154498310001
    PIRINCCIOGLU, Seyda
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    Geschäftsführer
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    EnglandTurkish152863060001
    SNOWDON, David John
    24 South Approach
    HA6 2ET Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    24 South Approach
    HA6 2ET Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish118974700001
    SWIFT, Nicholas
    34 The Grove
    AL9 7RN Brookmans Park
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    34 The Grove
    AL9 7RN Brookmans Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritish90315200001
    TYLER, Ian Paul
    Lime Tree House
    3b Village Road, Cockayne Hatley
    SG19 2EE Sandy
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Lime Tree House
    3b Village Road, Cockayne Hatley
    SG19 2EE Sandy
    Bedfordshire
    British66794160001
    VARCOE, Richard Antony Bruce, Dr
    105 Thingwall Park
    Fishponds
    BS16 2AR Bristol
    Geschäftsführer
    105 Thingwall Park
    Fishponds
    BS16 2AR Bristol
    United KingdomBritish55610930001
    VIVIAN, Simon Neil
    Pond Farm Cottage
    Faulkland
    BA3 5YG Bath
    Somerset
    Geschäftsführer
    Pond Farm Cottage
    Faulkland
    BA3 5YG Bath
    Somerset
    United KingdomBritish97479630001
    WENDT, Carsten Matthias, Dr
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    Geschäftsführer
    14 Castle Hill
    SL6 4JJ Maidenhead
    Hanson House
    GermanyGerman220319550003

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0