GREYCROFT HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGREYCROFT HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02550593
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GREYCROFT HOLDINGS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich GREYCROFT HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    68 Grafton Way 68 Grafton Way
    W1T 5DS London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GREYCROFT HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für GREYCROFT HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4th Floor Centre Heights 137 Finchley Road London NW3 6JG zum 68 Grafton Way 68 Grafton Way London W1T 5DS am 22. Dez. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 07. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Ernennung von Mr Malcolm William Froom Hezel als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Kathleen Bainbridge als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Okt. 2012

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    13 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Hamstead Park Hamstead Marshall Newbury Berks RG20 0HE geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Wer sind die Geschäftsführer von GREYCROFT HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HEZEL, Malcolm William Froom
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Hamstead Park
    Berks
    England
    Sekretär
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Hamstead Park
    Berks
    England
    182713390001
    GWYN JONES, Timothy
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish48297190002
    MORRIS, Nicholas Charles
    1 Montpelier Street
    SW7 1EX London
    Geschäftsführer
    1 Montpelier Street
    SW7 1EX London
    EnglandBritish72509780002
    BAINBRIDGE, Kathleen
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    Hamstead Park
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Berkshire
    British60082100001
    HARRISON, Dorothy Iris
    9 Ardilaun Road
    N5 2QR London
    Sekretär
    9 Ardilaun Road
    N5 2QR London
    British1808630001
    TURNER, Barry William
    3 Bolebec House
    10 Lowndes Street
    SW1X 9EU London
    Geschäftsführer
    3 Bolebec House
    10 Lowndes Street
    SW1X 9EU London
    New Zealand1808640002

    Hat GREYCROFT HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage deed
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 30. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a or being 214 fulham road london SW10 t/no BGL28. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage deed
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 30. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a or being land and buildings on the west side of froxmer street gorton manchester t/no LA234081. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of rental assignment
    Erstellt am 02. Apr. 1998
    Geliefert am 10. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title benefit and interest in the rents licence fees or other sums recoverable in respect of the properties described on the reverse of form 395 please see form for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bristol and West PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Commercial mortgage
    Erstellt am 02. Apr. 1998
    Geliefert am 10. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    214 fulham road kensington & chelsea BGL28,land on the west side of froxmer street city of manchester LA234081 land to the north east of broad street welshpool montgomeryshire powys WA527915 and other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 1998
    Geliefert am 10. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Aug. 1993
    Geliefert am 05. Aug. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    26 hanson street, city of westminster t/no: ln 241907 214 fulham road, r/b of kensington & chelsea t/no: bgl 28 by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 1992
    Geliefert am 04. Aug. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bristol and West Building Society
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Commercial mortgage deed
    Erstellt am 28. Juli 1992
    Geliefert am 04. Aug. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legalmortgage all estates rights title and other interests of the borrower in the property k/a 26 hanson street, london W1 title no. LN241907 together with all buildings structures and fixtures including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils stock furniture and equipment etc floating charge over all other the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Bristol and West Building Society
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Commercial mortgage deed
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee the offer letter and/or the charge
    Kurze Angaben
    All estates rights title and other interests of the company in the f/h property k/a 214 fulham road, l/b of kensington and chelsea title no. 322385 together with all buildings and fixtures(see form 395 for full property and other details).
    Berechtigte Personen
    • Bristol and West Building Society
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee the offer letter and/or the charge
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bristol and West Building Society
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land on the west side of froxmer street, manchester title no. LA234081. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Greycroft Limited
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the north east of broad street, welshpool, powys title no. WA527915. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Greycroft Limited
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H unit 22 walworth industrial estate, walworth, hampshire title no. HB423085. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Greycroft Limited
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings on the south side of swan lane, k/a swan village industrial estate, sandwell, west midlands title no. SF83350. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Greycroft Limited
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property at 214 fulham road, london SW10 in the royal borough of kensington & chelsea title no. 322385. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Greycroft Management Co. Limited
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0