MERCURY RECYCLING LIMITED: Geschäftsführer
Überblick
| Unternehmensname | MERCURY RECYCLING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02977989 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Wer sind die Geschäftsführer von MERCURY RECYCLING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAJI, Shenaz | Sekretär | Moss Side Industrial Estate PR26 7QS Leyland 117-118 Clydesdale Place Lancashire England | 262845480001 | |||||||
| EVANS, Paul John | Geschäftsführer | Moss Side Industrial Estate PR26 7QS Leyland 117-118 Clydesdale Place Lancashire England | England | British | 262845780001 | |||||
| ISAJI, Hassanali | Geschäftsführer | Moss Side Industrial Estate PR26 7QS Leyland 117-118 Clydesdale Place Lancashire England | England | British | 239773660003 | |||||
| KHAN, Abrar Hussain | Geschäftsführer | Moss Side Industrial Estate PR26 7QS Leyland 117-118 Clydesdale Place Lancashire England | United Kingdom | British | 75766660003 | |||||
| BAGNARA, Sandra | Sekretär | 56 Broseley Road Firswood Stretford M16 0FZ Manchester | British | 59602130002 | ||||||
| DUCKWORTH, Jennifer Susan | Sekretär | 13 Guildford Drive OL6 8UW Ashton Under Lyne Lancashire | British | 69753150001 | ||||||
| LEBOR, Simon | Sekretär | 41 Marlborough Mansions Cannon Hill NW6 1JS London | British | 40639570001 | ||||||
| SMALLEY, Caroline Jane | Sekretär | 35 Chapel Street Audenshaw M34 5DE Tameside | British | 52666020001 | ||||||
| SMITH-LAWRENCE, Dianne | Sekretär | 252 Heywood Road Prestwich M25 2GR Manchester Lancashire | British | 31951000001 | ||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| AVISON, James Ernest | Geschäftsführer | Minto Street OL7 9DA Ashton-Under-Lyne 66 Lancashire | England | British | 129722180001 | |||||
| BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett | Geschäftsführer | 7 Hillingdon Road Whitefield M45 7QQ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 2883500001 | |||||
| DWEK, Joseph Claude | Geschäftsführer | Suite One Courthill House 66 Water Lane SK9 4AP Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | 263624060001 | |||||
| LEBOR, Simon | Geschäftsführer | 41 Marlborough Mansions NW6 1JS London | United Kingdom | British | 20077170001 | |||||
| LEBOR, Simon | Geschäftsführer | 41 Marlborough Mansions NW6 1JS London | United Kingdom | British | 20077170001 | |||||
| LEON, Anthony Jack | Geschäftsführer | 2 Elm Road Didsbury M20 6XB Manchester | British | 32735900001 | ||||||
| MARSH, Andrew Joseph | Geschäftsführer | Vernon Street DE1 1FR Derby 8 England | England | British | 277069970001 | |||||
| NEILL, Bryan John | Geschäftsführer | 21 Springfield Road Gatley SK8 4PE Cheadle Cheshire | England | British | 46623720001 | |||||
| SMITH-LAWRENCE, Andrew David | Geschäftsführer | 252 Heywood Road Prestwich M25 2GR Manchester Lancashire | British | 31950990001 | ||||||
| SMITH-LAWRENCE, Dianne | Geschäftsführer | 252 Heywood Road Prestwich M25 2GR Manchester Lancashire | British | 31951000001 | ||||||
| WARDLE, Hugh | Geschäftsführer | Vernon Street DE1 1FR Derby 8 England | England | British | 45663030001 | |||||
| WRIGHT, Stuart | Geschäftsführer | Outram's Wharf DE21 5EL Little Eaton Sterling House Derbyshire United Kingdom | United Kingdom | British | 264622610001 | |||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0