ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03735410 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Waterside Business Park Livingstone Road HU13 0EG Hessle England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OVERCRAFT VENTURES LIMITED | 18. März 1999 | 18. März 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Mai 2019 bis 31. Jan. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Sterling Trust Financial Consulting Limited as a person with significant control on 28. Juni 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeffrey Grantham am 27. Feb. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 11 Waterside Business Park Livingstone Road Hessle HU13 0EG England zum 1 Waterside Business Park Livingstone Road Hessle HU13 0EG am 07. Juni 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jason Michael Reynolds als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Davison Holland als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ecs House, Unit 4 Broadfield Court Sheffield S8 0XF zum 11 Waterside Business Park Livingstone Road Hessle HU13 0EG am 22. Feb. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kathryn Anne Hague als Sekretär am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Parkin als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kathryn Anne Hague als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jeffrey Grantham als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Notification of Sterling Trust Financial Consulting Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 4 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Ecs Sheffield Ltd as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 3 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 21 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Mai 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jason Michael Reynolds am 03. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. März 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANTHAM, Jeffrey | Geschäftsführer | Waterside Business Park Livingstone Road HU13 0EG Hessle 1 England | United Kingdom | British | 220365630001 | |||||
| HAGUE, Kathryn Anne | Sekretär | 11 Dore Close S17 3PU Sheffield | British | 54559920005 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| EVANS, Brian Geoffrey | Geschäftsführer | East Orchard Claylands Road Whitwell S80 4QE Worksop | British | 3117300004 | ||||||
| HAGUE, Kathryn Anne | Geschäftsführer | 11 Dore Close S17 3PU Sheffield | England | British | 54559920005 | |||||
| HOLLAND, Christopher Davison | Geschäftsführer | 10 Ullswater Place Dronfield Woodhouse S18 8NX Dronfield Derbyshire | England | British | 112297300001 | |||||
| HUMPHREYS, Stuart Graham | Geschäftsführer | 8 Dalbury Road Dronfield Woodhouse S18 5YT Sheffield South Yorkshire | British | 23299860001 | ||||||
| PARKIN, Ian | Geschäftsführer | 34 Cherry Tree Drive Duckmanton S44 5JL Chesterfield Derbyshire | England | British | 90293300001 | |||||
| REYNOLDS, Jason Michael | Geschäftsführer | Livingstone Road HU13 0EG Hessle 11 Waterside Business Park England | England | British | 110011690004 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Trust Financial Consulting Limited | 31. Jan. 2018 | Livingstone Road HU13 0EG Hessle 1 Waterside Business Park England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ecs Sheffield Ltd | 27. Apr. 2016 | Broadfield Court S8 0XF Sheffield 4 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ECS FINANCIAL SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 10. Sept. 2011 Geliefert am 15. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Mai 2002 Geliefert am 09. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 27. Nov. 2000 Geliefert am 15. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0