WILLOWRIDGE TRADING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WILLOWRIDGE TRADING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04121439 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILLOWRIDGE TRADING LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich WILLOWRIDGE TRADING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 61 Rodney Street Liverpool L1 9ER |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLOWRIDGE TRADING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILLOWRIDGE TRADING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Mr Desmond Edward Walshe as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Dez. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Nicholl als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WILLOWRIDGE TRADING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALSHE, Desmond Edward | Sekretär | Flat 1 1 Allington Street L17 7AD Liverpool | British | 83589860002 | ||||||
| O'CONNELL WALSHE, Sandra | Geschäftsführer | 24 Offington Drive Sutton Dublin 13 Ireland | United Kingdom | Irish | 97209820001 | |||||
| WALSHE, Desmond Edward | Geschäftsführer | Flat 1 1 Allington Street L17 7AD Liverpool | England | British | 83589860002 | |||||
| POREMA LIMITED | Sekretär | 22 Northumberland Road D4 Ballsbridge Dublin 4 Republic Of Ireland | 74291480001 | |||||||
| CORDOBA, Alfonso Eirin | Geschäftsführer | Torca Road Dalkey 3 Co Dublin Ireland | Ireland | Irish | 147604310001 | |||||
| FOGARTY, Patrick | Geschäftsführer | Cornerstones Rugby Road IRISH Ranalagh Dublin 6 Ireland | Irish | 83589780001 | ||||||
| KAVANAGH, Sean | Geschäftsführer | 5 Cairn Manor Ratoath County Meath Republic Of Ireland | Ireland | Irish | 64329950003 | |||||
| NICHOLL, Martin | Geschäftsführer | Long Cootehill Cavan County Cavan Ireland | Great Britain | Irish | 97409700001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WILLOWRIDGE TRADING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Desmond Edward Walshe | 06. Apr. 2016 | 61 Rodney Street Liverpool L1 9ER | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat WILLOWRIDGE TRADING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 09. Aug. 2005 Geliefert am 11. Aug. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 133 knowsley road, bootle by way of fixed charge all rental income by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2004 Geliefert am 29. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property being 186 peel road bootle merseyside t/no MS178107 & t/no MS371658 by way of fixed charge all rental income by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 2003 Geliefert am 20. Dez. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The freehold and leasehold property known as alexandra mount litherland sefton merseyside t/no.s MS234269 and MS299759 and any part or parts thereof all buildings fixtures fittings plant and machinery all rental income the proceeds of any sale lease or other disposition by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture equipment and all other property assets and rights of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juni 2003 Geliefert am 12. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 47 gosford street liverpool L8 4SB, all rental income, all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 136 aigburgh road liverpool t/no: MS41444 all rental income and the. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Sept. 2002 Geliefert am 24. Sept. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 136 aigburth road liverpool. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0