INTEMPO DIGITAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINTEMPO DIGITAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05265109
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INTEMPO DIGITAL LIMITED?

    • (5143) /

    Wo befindet sich INTEMPO DIGITAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pricewaterhousecoopers Llp Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTEMPO DIGITAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für INTEMPO DIGITAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Aug. 2011

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2011

    8 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Apr. 2010

    9 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    8 Seiten2.34B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    9 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Okt. 2009

    6 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    12 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    27 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    13 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    13 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von INTEMPO DIGITAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRAHAM, David Thomas Burton
    5 Wilders Moor Close Ellenbrook
    Worsley
    M28 7GN Manchester
    Sekretär
    5 Wilders Moor Close Ellenbrook
    Worsley
    M28 7GN Manchester
    BritishDirector29810990003
    GARDNER, Robert Lyle
    Redhill House
    NG22 0BS Newark
    Notts
    Geschäftsführer
    Redhill House
    NG22 0BS Newark
    Notts
    EnglandBritishConsultant126736940001
    GRAHAM, David Thomas Burton
    5 Wilders Moor Close Ellenbrook
    Worsley
    M28 7GN Manchester
    Geschäftsführer
    5 Wilders Moor Close Ellenbrook
    Worsley
    M28 7GN Manchester
    EnglandBritishDirector29810990003
    SALTAIRE, Stephen Mark
    Cobblestones
    Hall Road
    CV32 5RA Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Cobblestones
    Hall Road
    CV32 5RA Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director80365260001
    SPOFFORTH, Bernadette
    Stamford Mill Farm
    Cotton Lane, Cotton Edmunds
    CH3 7QA Chester
    Geschäftsführer
    Stamford Mill Farm
    Cotton Lane, Cotton Edmunds
    CH3 7QA Chester
    EnglandBritishDirector39402390006
    RWL REGISTRARS LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    900007870001
    BROWN, Graham Martin
    Bayswater House Plowden Park
    OX9 5SX Aston Rowant
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Bayswater House Plowden Park
    OX9 5SX Aston Rowant
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector94522730001
    FORD, Anthony John
    Blake Hall
    Birch Vale
    SK12 5AY Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Blake Hall
    Birch Vale
    SK12 5AY Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant8421090002
    PARSLOW, Kevin
    31 Chaveney Walk
    LE12 8FH Quorn
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    31 Chaveney Walk
    LE12 8FH Quorn
    Leicestershire
    BritishDirector111674140001
    LLOYD STREET DIRECTORS LIMITED
    City Wharf
    New Bailey Street
    M3 5ER Manchester
    Geschäftsführer
    City Wharf
    New Bailey Street
    M3 5ER Manchester
    107191670001
    RWL DIRECTORS LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    90838080001

    Hat INTEMPO DIGITAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment of life policy
    Erstellt am 21. Aug. 2007
    Geliefert am 22. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its entire right title and interest in and to the policy being policy number L0193834072 with scottish equitable on the life of bernadette spofforth and any new or substituted policy which replaces that policy at any time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of life policy
    Erstellt am 21. Aug. 2007
    Geliefert am 22. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Entire right title and interest in and to the policy being policy number L0191144072 with scottish equitable on the life of david thomas burton graham and any new or substituted policy which replaces that policy at any time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Juli 2007
    Geliefert am 16. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Juli 2007
    Geliefert am 06. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hotbed Limited
    Transaktionen
    • 06. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 03. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Invoice finance agreement
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 03. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All moneys and liabilities all book and other debts revenues and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 2005
    Geliefert am 28. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 07. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge any debt of which ownership fails to vest absolutely and effectively together with the proceeds of such debt, all amounts owing or becoming due and all amounts of indebtedness owing or due on any account whatsoever and their proceeds together with the related rights and their proceeds. By way of floating charge the undertaking and all other property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Target Trade Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All f/h and l/h property vested in the company all estates and interests in any f/h and l/h property from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Enterprise Finance Europe (UK) LTD
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Nov. 2004
    Geliefert am 27. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ups Capital UK LTD
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat INTEMPO DIGITAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Apr. 2009Beginn der Verwaltung
    19. Apr. 2010Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Mark Oldfield
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    David Thornhill
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Praktiker
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Nicholas Edward Reed
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    2
    DatumTyp
    19. Apr. 2010Beginn der Liquidation
    30. Nov. 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas Edward Reed
    Pricewaterhousecoopers Llp Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Stephen Mark Oldfield
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Abacus House
    CB3 0AN Castle Park
    Cambridge

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0