CHURCHILL PROPERTIES LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHURCHILL PROPERTIES LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 05361878
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHURCHILL PROPERTIES LTD?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CHURCHILL PROPERTIES LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    71 Marlowe Road
    CH44 3DF Wallasey
    Merseyside
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHURCHILL PROPERTIES LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHURCHILL PROPERTIES LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 28. Feb. 2018 bis 31. Aug. 2018

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 28. Feb. 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2016

    6 SeitenAA

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 18. Mai 2016

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 23. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 200
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Additions 24 Queen Avenue Liverpool L2 4TZ* am 07. März 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2013

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 61 Stanley Road Bootle L20 7BZ* am 21. Nov. 2013

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2012

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2009

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CHURCHILL PROPERTIES LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HIBBERD, Angela Marilyn
    44 Wellington Road
    New Brighton
    CH45 2NG Wallasey
    Merseyside
    Sekretär
    44 Wellington Road
    New Brighton
    CH45 2NG Wallasey
    Merseyside
    BritishNone5430330001
    HIBBERD, Joseph
    71 Marlowe Road
    CH44 3DE Wallasey
    Merseyside
    Geschäftsführer
    71 Marlowe Road
    CH44 3DE Wallasey
    Merseyside
    EnglandBritishDirector87670280002
    HIBBERD, Joseph
    4 Winchester Drive
    CH44 2AZ Wallasey
    Merseyside
    Sekretär
    4 Winchester Drive
    CH44 2AZ Wallasey
    Merseyside
    BritishDirector87670280001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    LE GROS, David
    25 The Copse
    Calderstones
    L18 3NH Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    25 The Copse
    Calderstones
    L18 3NH Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector84575080003
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHURCHILL PROPERTIES LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Joseph Hibberd
    Marlowe Road
    CH44 3DF Wallasey
    71
    Merseyside
    06. Apr. 2016
    Marlowe Road
    CH44 3DF Wallasey
    71
    Merseyside
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat CHURCHILL PROPERTIES LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2007
    Geliefert am 31. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    1A taylor street birkenhead. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Okt. 2007
    Geliefert am 23. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land adjoining bryn melyn penmaenmawr t/n WA782096. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Aug. 2007
    Geliefert am 01. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    10 keswick road, wallasey, wirral, merseyside. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on deposit
    Erstellt am 17. Apr. 2007
    Geliefert am 18. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Account number 61830796 opened in the name of churchill properties limited with the bank and all rights of churchill properties limited in relation to such account.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 2007
    Geliefert am 21. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H 217 rake lane wallasey t/no MS77065. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 2007
    Geliefert am 21. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H 211 rake lane wallasey t/no MS486467. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Feb. 2007
    Geliefert am 21. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    211 and 217 rake lake wallasey fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Mai 2005
    Geliefert am 02. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    217 rake lane, wallasey, merseyside, CH45 5DQ t/n MS77065,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Mai 2005
    Geliefert am 07. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0