ASSISTED LIVING SOUTH WEST (PROPCO) LIMITED: Geschäftsführer

  • Überblick

    UnternehmensnameASSISTED LIVING SOUTH WEST (PROPCO) LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 06569211
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Wer sind die Geschäftsführer von ASSISTED LIVING SOUTH WEST (PROPCO) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JALIL, Sujahan Begum
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    EnglandBritish159459470008
    KOUSAR, Rehana
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    Geschäftsführer
    50 Rocky Lane
    Aston
    B6 5RQ Birmingham
    Nexus House, Aston Cross Business Park
    West Midlands
    England
    EnglandBritish240253740004
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Sekretär
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    158661230001
    MCLEISH, William David
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Sekretär
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    British168970640001
    MH SECRETARIES LIMITED
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Sekretär
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2893220
    39754020001
    BERRY, Dawn Allyson
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    Geschäftsführer
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    United KingdomBritish208169400001
    BUCHAN, William James
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Geschäftsführer
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    EnglandBritish79917240001
    BURTON, David
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    EnglandBritish236544840001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DOUGLAS, James Barclay
    -3 Welland Court
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    Geschäftsführer
    -3 Welland Court
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish159117650001
    FAHY, John Douglas
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Emperor Way
    Exeter Business Park
    EX1 3QS Exeter
    1
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritish159117670001
    FOULKES, Kamma
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Geschäftsführer
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    KIRKPATRICK, Paul
    17a Friary Road
    NG24 1LE Newark
    Friary House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    17a Friary Road
    NG24 1LE Newark
    Friary House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish124307020001
    LENNOX, Andrew Gordon
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    Geschäftsführer
    Elliott Court
    Coventry Business Park
    CV5 6UB Coventry
    1110
    England
    United KingdomBritish185434680001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Geschäftsführer
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MOSS, Paul Michael
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8DN Tewkesbury
    Unit 21 Miller Court
    Gloucestershire
    England
    Geschäftsführer
    Severn Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8DN Tewkesbury
    Unit 21 Miller Court
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish1993340004
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    SCANDRETT, Barbara
    -3 Welland Court
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    Geschäftsführer
    -3 Welland Court
    Welland Court, Brockeridge Park Twyning
    GL20 6FD Tewkesbury
    1
    Gloucestershire
    England
    WalesBritish161743730001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    Geschäftsführer
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    YOUNG, Katrine Lilias
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Staple Court
    United Kingdom
    UkBritish172973980001

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0