CAPABILITY SCOTLAND: Geschäftsführer

  • Überblick

    UnternehmensnameCAPABILITY SCOTLAND
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer SC036524
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Wer sind die Geschäftsführer von CAPABILITY SCOTLAND?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PHILIP, Andrew
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Sekretär
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    258753130001
    ALEXANDER, Ronald Stuart
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish289305230001
    BINGHAM, Brian John Graham
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish90279220001
    BRITAIN, Amanda Kate
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish301464230001
    CAMERON, Alexander, Professor
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish117647900002
    GILMOUR, Christopher
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    EnglandBritish131538400002
    HOURSTON, David
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish301487660001
    MCPHERSON, Lisa Margaret
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish160309300005
    PAYTON, Malcolm Neil, Mr.
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish121010870001
    THOMSON, Gavin
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish318410730001
    WALLACE, Rachael, Dr
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandScottish342702560001
    DICKSON, Alan David James
    Lowland Cottage
    EH48 4LQ Bathgate
    West Lothian
    Sekretär
    Lowland Cottage
    EH48 4LQ Bathgate
    West Lothian
    British8882040002
    DICKSON, Alan David James
    Lowland Cottage
    EH48 4LQ Bathgate
    West Lothian
    Sekretär
    Lowland Cottage
    EH48 4LQ Bathgate
    West Lothian
    British8882040002
    FINNIGAN, George
    Thistledene
    Niddry Road
    EH52 6PP Winchburgh
    West Lothian
    Sekretär
    Thistledene
    Niddry Road
    EH52 6PP Winchburgh
    West Lothian
    Scottish114905290001
    HELLEWELL, Richard Geoffrey
    8 Colmestone Gate
    EH10 6QP Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    8 Colmestone Gate
    EH10 6QP Edinburgh
    Midlothian
    British69927300002
    MCBAIN, Ian Gilchrist
    Meadowburn 44 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5DZ Glasgow
    Lanarkshire
    Sekretär
    Meadowburn 44 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5DZ Glasgow
    Lanarkshire
    British27220540001
    BISHOPS
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Sekretär
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    83486520001
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor Quartermile Two
    Scotland
    Sekretär
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor Quartermile Two
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC262093
    95512800001
    ALEXANDER, Ronald Stuart
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    Geschäftsführer
    24 St Johns Road
    EH12 6NZ Edinburgh
    Vantage Point
    Scotland
    ScotlandBritish289305230001
    ALLEN, Mairi Elly Granlie
    17 Torridon Walk
    EH54 5AT Livingston
    West Lothian
    Geschäftsführer
    17 Torridon Walk
    EH54 5AT Livingston
    West Lothian
    British977040001
    BARBOUR, Janice
    12 Breadalbane Terrace
    Friarton
    PH2 8BY Perth
    Perth & Kinross
    Geschäftsführer
    12 Breadalbane Terrace
    Friarton
    PH2 8BY Perth
    Perth & Kinross
    British74518300002
    BARCLAY, Robert Peter Clarkston, Doctor
    33 Mousebank Road
    ML11 7PE Lanark
    Geschäftsführer
    33 Mousebank Road
    ML11 7PE Lanark
    British977030001
    BLACKLOCK, Patricia Mary Anne
    Stable House
    Maxton
    TD6 0EX St Boswells
    Roxburghshire
    Geschäftsführer
    Stable House
    Maxton
    TD6 0EX St Boswells
    Roxburghshire
    British26670001
    CURRIE, David
    c/o C/O Morton Fraser Llp
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Geschäftsführer
    c/o C/O Morton Fraser Llp
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    ScotlandBritish54495650003
    CURRIE, David
    Ard Mhuirich
    HS3 3AR Cliasmol
    Isle Of Harris
    Geschäftsführer
    Ard Mhuirich
    HS3 3AR Cliasmol
    Isle Of Harris
    ScotlandBritish54495650003
    D'AGUILAR, Jonathan Anthony Peter
    c/o C/O Morton Fraser Llp
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Geschäftsführer
    c/o C/O Morton Fraser Llp
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    ScotlandBritish141457020001
    DAVIE, Elaine
    285 Bath Street
    G2 4JL Glasgow
    Berkeley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    285 Bath Street
    G2 4JL Glasgow
    Berkeley House
    Scotland
    ScotlandBritish149871950001
    DAVIES, Martha Esther Heti
    Old Cottage School
    38 Hadfast Road
    EH22 2NZ Cousland
    Midlothian
    Geschäftsführer
    Old Cottage School
    38 Hadfast Road
    EH22 2NZ Cousland
    Midlothian
    British25942370002
    DAY, Ruth Elizabeth, Doctor
    4 Stirling Drive
    Bearsden
    G61 4NX Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    4 Stirling Drive
    Bearsden
    G61 4NX Glasgow
    Lanarkshire
    British32151600002
    DICKSON, Alan David James
    Lowland Cottage
    EH48 4LQ Bathgate
    West Lothian
    Geschäftsführer
    Lowland Cottage
    EH48 4LQ Bathgate
    West Lothian
    United KingdomBritish8882040002
    DOUGLAS, Alexander Blackie
    5 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    5 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    British30643810001
    DRYSDALE, William
    The Old Schoolhouse 25 Cramond Glebe Road
    EH4 6NT Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    The Old Schoolhouse 25 Cramond Glebe Road
    EH4 6NT Edinburgh
    Midlothian
    British32884370002
    DUFFIELD, Sheelagh Jane
    197 Queen Victoria Drive
    Scotstounhill
    G14 9BP Glasgow
    Geschäftsführer
    197 Queen Victoria Drive
    Scotstounhill
    G14 9BP Glasgow
    ScotlandBritish52720790003
    EDWARDS, Frederick Edward, Dr
    Gardenfield
    Ninemileburn
    EH26 9LT Midlothian
    Geschäftsführer
    Gardenfield
    Ninemileburn
    EH26 9LT Midlothian
    British36863300001
    EDWARDSON, Patrick James
    Bughtknowe House
    EH36 5PB Humbie
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Bughtknowe House
    EH36 5PB Humbie
    East Lothian
    ScotlandBritish105328130002

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0