WHEATLEY HOMES SOUTH LIMITED: Geschäftsführer

  • Überblick

    UnternehmensnameWHEATLEY HOMES SOUTH LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer SC220297
    GerichtsbarkeitSchottland
    Gründungsdatum

    Wer sind die Geschäftsführer von WHEATLEY HOMES SOUTH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALLISON, Anthony
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    United Kingdom
    Sekretär
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    United Kingdom
    267939800001
    CAMPBELL, Helen Elizabeth
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    EnglandBritish138279160001
    CARRUTHERS, David Donald
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    United KingdomBritish160721170003
    CLARK HUTCHISON, Alison Jane
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    United KingdomBritish344469280001
    GREAVES - MACKINTOSH, Michael Christopher
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    United KingdomBritish238775380001
    HENDERSON, John Maxwell Houston
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    United KingdomBritish539650001
    HUNTER, Karen Margaret
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    ScotlandBritish307641320001
    LEGG, Garry Alan
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    ScotlandScottish314039750001
    POLLARD, Joan Violet
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    United KingdomBritish58896660001
    TOTTON, Josephine Catherine
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    EnglandBritish288653210002
    CRAIG, Kirsten Mary
    The Crichton
    Bankend Road
    DG1 4ZS Dumfries
    Grierson House
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    Sekretär
    The Crichton
    Bankend Road
    DG1 4ZS Dumfries
    Grierson House
    Dumfries And Galloway
    Scotland
    British158797980001
    FORSTER, Zoe
    Bankend Road
    DG1 4ZS Dumfries
    Grierson House
    Scotland
    Sekretär
    Bankend Road
    DG1 4ZS Dumfries
    Grierson House
    Scotland
    184168900001
    FORSTER, Zoe
    Croft House
    CA3 0JS Tarraby
    Carlisle
    Sekretär
    Croft House
    CA3 0JS Tarraby
    Carlisle
    British87221710001
    JARVIS, Jonathan Edward Madison
    Flat 1 Mayfair Court
    15 Park Hill Rise
    CR0 5RU Croydon
    Sekretär
    Flat 1 Mayfair Court
    15 Park Hill Rise
    CR0 5RU Croydon
    British65969460001
    MINTO, Paul
    9 Moffat Road
    DG1 1NN Dumfries
    Dumfries 7 Galloway
    Sekretär
    9 Moffat Road
    DG1 1NN Dumfries
    Dumfries 7 Galloway
    British77143590001
    MINTO, Paul
    9 Moffat Road
    DG1 1NN Dumfries
    Dumfries 7 Galloway
    Sekretär
    9 Moffat Road
    DG1 1NN Dumfries
    Dumfries 7 Galloway
    British77143590001
    MOORE, Jayne
    6 Burnbrae
    DG3 5DY Thornhill
    Dumfriesshire
    Sekretär
    6 Burnbrae
    DG3 5DY Thornhill
    Dumfriesshire
    British122663560001
    MOWAT, Eilidh
    Grierson House
    The Crichton
    DG1 4ZS Bankend Road
    Dumfries,
    Sekretär
    Grierson House
    The Crichton
    DG1 4ZS Bankend Road
    Dumfries,
    251951320001
    O'BRYAN, Ben
    19 James Close
    Woodlands
    NW11 9QX London
    Sekretär
    19 James Close
    Woodlands
    NW11 9QX London
    British76436090001
    TODD, Paul
    62 Coogan Close
    CA2 5SG Carlisle
    Cumbria
    Sekretär
    62 Coogan Close
    CA2 5SG Carlisle
    Cumbria
    British120567580001
    ARMSTRONG, Adam Scott
    37 Townfoot
    DG13 0EH Langholm
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    37 Townfoot
    DG13 0EH Langholm
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish71559680001
    BENNEY, Peter John
    8 Bracken Wood
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2FA Castle Douglas
    Dumfries & Galloway
    Geschäftsführer
    8 Bracken Wood
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2FA Castle Douglas
    Dumfries & Galloway
    British99724000001
    BRADY, William
    114 Loanwath Road
    DG16 5BX Gretna
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    114 Loanwath Road
    DG16 5BX Gretna
    Dumfriesshire
    British108777350001
    BROWN, Margaret
    Brooms Road
    DG1 2EB Dumfries
    152
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    Brooms Road
    DG1 2EB Dumfries
    152
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish137041890001
    BURDEN, Fiona
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    ScotlandBritish263005180001
    CARNOCHAN, Robert George
    Ashyards Court
    Eaglesfield
    DG11 3PE Lockerbie
    12 Ashyards Court
    Dumfries & Galloway
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashyards Court
    Eaglesfield
    DG11 3PE Lockerbie
    12 Ashyards Court
    Dumfries & Galloway
    United Kingdom
    United KingdomBritish215190660001
    CARRUTHERS, Bruce Robert
    1 Margaret Drive
    DG11 2PE Lockerbie
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    1 Margaret Drive
    DG11 2PE Lockerbie
    Dumfriesshire
    British77143250001
    CASTLE, Beryl Nelley Henriette
    Corehead House Annan Water
    D910 9LT Moffat
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    Corehead House Annan Water
    D910 9LT Moffat
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish94162460001
    CLARK, Irene
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Whetley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Whetley House
    Scotland
    ScotlandBritish45037030002
    COLLINS, Brian
    13 Braeside
    New Galloway
    DG7 3RU Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Geschäftsführer
    13 Braeside
    New Galloway
    DG7 3RU Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    ScotlandBritish110717490001
    DORBY, Martin
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    ScotlandBritish323977030001
    DOWDEN, Maureen
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    Geschäftsführer
    25 Cochrane Street
    G1 1HL Glasgow
    Wheatley House
    Scotland
    ScotlandBritish191721380001
    DRYBURGH, Archie
    14 Princes Avenue
    DG12 5LA Annan
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    14 Princes Avenue
    DG12 5LA Annan
    Dumfriesshire
    British124366270001
    DUFF, Gordon
    Queensway
    DG12 5JU Annan
    38
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    Queensway
    DG12 5JU Annan
    38
    Dumfriesshire
    British146294760001
    DUNCAN, James
    Hornel Road
    DG6 4LH Kirkcudbright
    23
    Kirkcudbrightshire
    Geschäftsführer
    Hornel Road
    DG6 4LH Kirkcudbright
    23
    Kirkcudbrightshire
    Scotland United KingdomBritish108777240001

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0