NATIONAL CENTRE FOR MUSIC: Einreichungen
Überblick
Unternehmensname | NATIONAL CENTRE FOR MUSIC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital, Befreiung von der Verwendung von 'Limited' |
Unternehmensnummer | SC764132 |
Gerichtsbarkeit | Schottland |
Gründungsdatum |
Welche sind die letzten Einreichungen für NATIONAL CENTRE FOR MUSIC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Carol Elizabeth Nimmo am 01. Apr. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Colin Macduff Liddell am 01. Apr. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von J & H Mitchell Llp als Sekretär am 01. Apr. 2025 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||||||||||
Cessation of Carol Elizabeth Nimmo as a person with significant control on 21. Jan. 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Carol Betsy Lees Dickson Main as a person with significant control on 21. Jan. 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Andrew Colin Macduff Liddell as a person with significant control on 21. Jan. 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Dunard Fund as a person with significant control on 21. Jan. 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Ernennung von Jennifer Catriona Jamison als Direktor am 21. Jan. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 32 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 51 Atholl Road Pitlochry Perthshire PH16 5BU zum Colinton Suite Strathmore Offices 91 George Street Edinburgh EH2 3ES am 20. Jan. 2025 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2024 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Carol Elizabeth Nimmo as a person with significant control on 30. Mai 2024 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Amanda Jean Forsyth als Geschäftsführer am 30. Mai 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Carol Elizabeth Nimmo als Direktor am 30. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Cessation of Amanda Jean Forsyth as a person with significant control on 30. Mai 2024 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Royal High School Preservation Trust as a person with significant control on 13. Sept. 2023 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Carol Betsy Lees Dickson Main am 19. Apr. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Amanda Jean Forsyth am 18. März 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Carol Betsy Lees Dickson Main als Direktor am 26. Sept. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Notification of Carol Betsy Lees Dickson Main as a person with significant control on 26. Sept. 2023 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William John Gray Muir als Geschäftsführer am 21. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0