Nigel Mark Inches ROBERTSON
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Nigel |
| Zweites Vornamen | Mark Inches |
| Nachname | ROBERTSON |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 0 |
| Zurückgetreten | 18 |
| Gesamt | 19 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS FERTILITY TOPCO LIMITED | 22. März 2023 | Aktiv | Geschäftsführer | High Street Higham Ferrers NN10 8BW Rushden Carlton House Northamptonshire England | England | British | ||
| CARE FERTILITY HOLDINGS LIMITED | 10. Mai 2019 | 30. Sept. 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Carter Lane EC4V 5ER London One England | England | British | |
| CARE FERTILITY GROUP LIMITED | 27. Juni 2016 | 30. Sept. 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | |
| ASTON LARK (TOPCO) LIMITED | 18. Sept. 2017 | 02. Sept. 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Ibex House 42-47 Minories EC3N 1DY London 8th Floor United Kingdom | England | British | |
| BATH FERTILITY CENTRE LIMITED | 07. Feb. 2019 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | England | British | |
| CARE FERTILITY LEEDS LIMITED | 10. Jan. 2019 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House United Kingdom | England | British | |
| CARE FERTILITY LIVERPOOL LIMITED | 20. Sept. 2018 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House United Kingdom | England | British | |
| ZITA WEST ASSISTED FERTILITY LIMITED | 31. Mai 2017 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive, Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | England | British | |
| ZITA WEST CLINICS LIMITED | 31. Mai 2017 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive, Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | England | British | |
| CENTRE FOR REPRODUCTIVE MEDICINE LIMITED | 27. Juni 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | |
| CARE FERTILITY BIRMINGHAM LIMITED | 27. Juni 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House England | England | British | |
| CARE (SHEFFIELD) LIMITED | 27. Juni 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | |
| SOUTH EAST FERTILITY CLINIC LTD | 27. Juni 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House Nottinghamshire | England | British | |
| CARE FERTILITY (NORTHAMPTON) LIMITED | 27. Juni 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | |
| CARE FERTILITY (LONDON) LIMITED | 27. Juni 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | |
| CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED | 27. Juni 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | |
| RACHEL TOPCO LIMITED | 01. Jan. 2016 | 10. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | 6 Lawrence Drive Nottingham Business Park NG8 6PZ Nottingham John Webster House | England | British | |
| ASTON LARK (AT) LIMITED | 01. Juli 2016 | 18. Sept. 2017 | Aufgelöst | Geschäftsführer | St. Peters Hill PE9 2PE Stamford 8 Lincolnshire England | England | British | |
| ML CONVENIENCE LIMITED | 14. Nov. 2014 | 01. Apr. 2015 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Gain Lane BD3 7DL Bradford Hilmore House West Yorkshire | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0