James Shanks HALLIDAY
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | James |
Zweites Vornamen | Shanks |
Nachname | HALLIDAY |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 3 |
Inaktiv | 20 |
Zurückgetreten | 9 |
Gesamt | 32 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERNO BKB LTD | 01. Juni 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | c/o James Halliday Cotton Vale Dalziel Park Est ML1 5NL Motherwell 14 Lanarkshire | Scotland | British | |
Q GUARDIAN LTD | 27. Mai 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Garrion Business Park ML2 0RY Wishaw Smith Avenue Scotland | Scotland | British | |
JD MANUFACTURING & CONSTRUCTION LTD | 16. Juli 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Garrion Business Park Smith Avenue ML2 0RY Wishaw No 2a Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | |
KITCHENS FOR TRADE LTD | 21. Dez. 2018 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | Garrion Business Park Smith Avenue ML2 0RY Wishaw Unit 2a Scotland | Scotland | British | |
GO 4 KITCHENS LIMITED | 23. Juli 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Glasgow Road ML2 7SN Wishaw 539 Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | |
PICK YOUR FLOORS WHOLESALE LTD | 23. Mai 2017 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell 14 United Kingdom | Scotland | British | |
PICK YOUR TRADE LTD | 31. Okt. 2016 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Dalziel Park Est ML1 5NL Motherwell 14 Cotton Vale United Kingdom | Scotland | British | |
THOLOS AVIATION LIMITED | 26. März 2012 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Rosebank Road EH54 7EJ Livingston 3b West Lothian United Kingdom | Scotland | British | |
WEIGHT ANGEL SYSTEMS LIMITED | 24. Nov. 2011 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Rosebank Park EH54 7EJ Livingston Unit 3b Midlothian Uk | Scotland | British | |
THOLOS TECHNOLOGY LIMITED | 12. Sept. 2011 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Rosebank Park EH54 7EJ Livingston Unit 3b Midlothian Scotland | Scotland | British | |
CASTSAID LIMITED | 18. März 2011 | Aufgelöst | Consultant | Geschäftsführer | Cottonvale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell 14 Scotland | Scotland | British | |
SAFE TRAVEL LIMITED | 01. Sept. 2010 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell 14 | Scotland | British | |
COTHROM CARE LTD. | 10. Mai 2010 | Aufgelöst | Care Manager | Geschäftsführer | Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell 14 North Lanarkshire | Scotland | British | |
CAMVO 504 LIMITED | 03. Juni 2008 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British | |
ACCESS DENTAL CARE (SMILE DENTAL) LIMITED | 19. Dez. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | British | |||
ACCESS DENTAL CARE LLP | 07. Dez. 2006 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell Lanarkshire | Scotland | |||
ACCESS DENTAL CARE (HUSH AND SMILE) LIMITED | 04. Dez. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | British | |||
CHELSEA HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED | 05. Apr. 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British | |
BRIDGESTAR LIMITED | 01. Nov. 2004 | Aufgelöst | Company Director | Sekretär | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | British | ||
DADDY DAY CARE LIMITED | 28. Juni 2004 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | British | |||
DAIGEIL LIMITED | 28. Mai 2002 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British | |
S & H PROPERTIES LTD. | 09. Juni 2000 | Aufgelöst | Sekretär | Carnegie Campus Carnegie Campus KY11 8PB Dunfermline 3 Fife | British | |||
S & H PROPERTIES LTD. | 09. Juni 2000 | Aufgelöst | Business Development Adviser | Geschäftsführer | Carnegie Campus Carnegie Campus KY11 8PB Dunfermline 3 Fife | Scotland | British | |
MODERNO BKB LTD | 28. Juni 2004 | 01. Juni 2022 | Aktiv | Sekretär | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | British | ||
PLATINUM RESOURCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 11. Sept. 2015 | 03. Aug. 2017 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 19 Dalziel House ML1 2SJ Motherwell Dalziel House Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British |
CAMVO 37 LIMITED | 08. Aug. 2001 | 01. März 2015 | Insolvenzverfahren | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British |
LUGGIEBANK LLP | 29. Juni 2009 | 30. Juni 2009 | Aktiv | Bestelltes Mitglied der LLP | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell Lanarkshire | Scotland | ||
SAFE TRAVEL LIMITED | 15. Mai 2007 | 06. Nov. 2007 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British |
CHOICES HEALTHCARE LIMITED | 01. Jan. 2003 | 24. Feb. 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British |
CHOICES PROPERTY LIMITED | 27. Mai 2002 | 24. Feb. 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British |
CHOICES (HOLDINGS) LIMITED | 26. Apr. 2000 | 24. Feb. 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British |
CHOICES (S.O.S.) LIMITED | 18. Feb. 2000 | 24. Feb. 2006 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Cotton Vale Dalziel Park Estate ML1 5NL Motherwell North Lanarkshire | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0