Rachel Mary OLIVER
Natürliche Person
| Titel | Miss | 
|---|---|
| Vorname | Rachel | 
| Zweites Vornamen | Mary | 
| Nachname | OLIVER | 
| Ist Unternehmensleiter | Nein | 
| Ernennungen | |
| Aktiv | 8 | 
| Inaktiv | 13 | 
| Zurückgetreten | 44 | 
| Gesamt | 65 | 
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITESCORE LIMITED | 31. Mai 2007 | Aufgelöst | Sekretär | 11 Jackson Avenue DE3 9AS  Derby Derbyshire | British | |||
| BASE TWO LTD | 05. März 2007 | Aufgelöst | Sekretär | 11 Jackson Avenue DE3 9AS  Derby Derbyshire | British | |||
| A R WHITE BUILDING LIMITED | 01. Juni 2006 | Aktiv | Sekretär | 106 - 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse England | British | |||
| HAWTHORN PRODUCTIONS LIMITED | 12. Apr. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |||
| FORCE 10 WINDOWS LIMITED | 15. Aug. 2005 | Aufgelöst | Counsellor | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire | British | ||
| CHAIN & SPROCKET ENGINEERING LIMITED | 30. Juni 2004 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |||
| COMMUNICATE (BUSINESS COMMUNICATIONS) LIMITED | 17. Juni 2003 | Aufgelöst | Secretary | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | ||
| CEDAR + CO. GROUP LTD | 25. Apr. 2003 | Aktiv | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road Derby DE22 3AG  | British | |||
| CEDAR + CO. GROUP LTD | 25. Apr. 2003 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 106-108 Ashbourne Road Derby DE22 3AG  | England | British | |
| GREEN 2 K DESIGN LIMITED | 26. März 2003 | Aktiv | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse | British | |||
| FIRST BASE (UK) LIMITED | 10. Feb. 2003 | Aktiv | Counsellor | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire | British | ||
| FIRST BASE (UK) LIMITED | 10. Feb. 2003 | Aktiv | Counsellor | Geschäftsführer | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire | England | British | |
| RUSS-STIMSON.COM LIMITED | 15. Aug. 2002 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |||
| MATTOCK SYSTEMS LIMITED | 01. Aug. 2002 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |||
| MAUREEN RIVERS LIMITED | 08. Juli 2002 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |||
| ERGONOMICS AND REHABILITATION SERVICES LIMITED | 08. Juli 2002 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |||
| JIC CONCEPTS LIMITED | 09. Mai 2002 | Aufgelöst | Sekretär | Stanford House 19 Castle Gate NG1 7AQ  Nottingham C/O Frp Advisory Llp England | British | |||
| UNITED IN DESIGN LIMITED | 01. Feb. 2002 | Aktiv | Secretary | Sekretär | 106 - 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse England | British | ||
| CZECH CHOC LTD | 23. Nov. 2001 | Aufgelöst | Sekretär | 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire United Kingdom | British | |||
| HILTON HOUSE HOTEL LIMITED | 28. März 2000 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |||
| ACCOUNTANCY & ADVICE FOR SMALL BUSINESSES LIMITED | 05. Feb. 1999 | Aktiv | Manager | Geschäftsführer | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse | United Kingdom | British | |
| C A TIMM CONTRACT SERVICES LIMITED | 12. Juli 2002 | 08. Nov. 2018 | Aufgelöst | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire | British | ||
| PEAK CONTRACTS LIMITED | 14. März 2005 | 19. März 2018 | Aktiv | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse England | British | ||
| SAP DATA MIGRATORS LTD | 10. Juli 2006 | 15. Sept. 2016 | Aktiv | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire | British | ||
| HIGGS CAFE BAR LIMITED | 16. Juli 2002 | 16. Juni 2014 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | ||
| SILKTIDE LIMITED | 07. Feb. 2006 | 09. Mai 2014 | Aktiv | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | ||
| THE COMPASSIONATE MIND FOUNDATION | 26. Juli 2006 | 09. Sept. 2013 | Aktiv | Secretary | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |
| SAFETY REFLECTIVES LIMITED | 01. Okt. 2004 | 19. März 2013 | Aufgelöst | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire United Kingdom | British | ||
| THE SIGN & PRINT CENTRE LIMITED | 30. Juni 2003 | 09. Jan. 2013 | Aufgelöst | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | ||
| NEXTGEN SERVERS LIMITED | 17. Jan. 2008 | 01. Dez. 2012 | Aufgelöst | Sekretär | 11 Jackson Avenue DE3 9AS  Derby Derbyshire | British | ||
| LLOYD AIR LIMITED | 09. Aug. 1999 | 30. Nov. 2012 | Aufgelöst | Secretary | Sekretär | Lucre House 108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby Derbyshire | British | |
| OPTIK PROPERTIES LIMITED | 16. Aug. 2004 | 22. Aug. 2012 | Aktiv | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire | British | ||
| OPTIK LEISURE LIMITED | 15. Aug. 2002 | 22. Aug. 2012 | Aktiv | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire | British | ||
| VICKELL PUBLICATION SERVICES LIMITED | 09. Aug. 1999 | 11. Mai 2012 | Aufgelöst | Secretary | Sekretär | 106-108 Ashbourne Road DE22 3AG  Derby The Greenhouse Derbyshire United Kingdom | British | |
| MAXAM UK LIMITED | 03. Juni 2008 | 23. Feb. 2012 | Aktiv | Sekretär | 11 Jackson Avenue DE3 9AS  Derby Derbyshire | British | 
Datenquelle
- UK Companies House 
 Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
- Lizenz: CC0