• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Rachel Mary OLIVER

    Natürliche Person

    TitelMiss
    VornameRachel
    Zweites VornamenMary
    NachnameOLIVER
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv8
    Inaktiv13
    Zurückgetreten44
    Gesamt65

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    SITESCORE LIMITED31. Mai 2007AufgelöstSekretär
    11 Jackson Avenue
    DE3 9AS Derby
    Derbyshire
    British
    BASE TWO LTD05. März 2007AufgelöstSekretär
    11 Jackson Avenue
    DE3 9AS Derby
    Derbyshire
    British
    A R WHITE BUILDING LIMITED01. Juni 2006AktivSekretär
    106 - 108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    England
    British
    HAWTHORN PRODUCTIONS LIMITED12. Apr. 2006AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    FORCE 10 WINDOWS LIMITED15. Aug. 2005AufgelöstCounsellorSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    British
    CHAIN & SPROCKET ENGINEERING LIMITED30. Juni 2004AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    COMMUNICATE (BUSINESS COMMUNICATIONS) LIMITED17. Juni 2003AufgelöstSecretarySekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    CEDAR + CO. GROUP LTD25. Apr. 2003AktivSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    Derby
    DE22 3AG
    British
    CEDAR + CO. GROUP LTD25. Apr. 2003AktivDirectorGeschäftsführer
    106-108 Ashbourne Road
    Derby
    DE22 3AG
    EnglandBritish
    GREEN 2 K DESIGN LIMITED26. März 2003AktivSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    British
    FIRST BASE (UK) LIMITED10. Feb. 2003AktivCounsellorSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    British
    FIRST BASE (UK) LIMITED10. Feb. 2003AktivCounsellorGeschäftsführer
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    EnglandBritish
    RUSS-STIMSON.COM LIMITED15. Aug. 2002AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    MATTOCK SYSTEMS LIMITED01. Aug. 2002AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    MAUREEN RIVERS LIMITED08. Juli 2002AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    ERGONOMICS AND REHABILITATION SERVICES LIMITED08. Juli 2002AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    JIC CONCEPTS LIMITED09. Mai 2002AufgelöstSekretär
    Stanford House
    19 Castle Gate
    NG1 7AQ Nottingham
    C/O Frp Advisory Llp
    England
    British
    UNITED IN DESIGN LIMITED01. Feb. 2002AktivSecretarySekretär
    106 - 108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    England
    British
    CZECH CHOC LTD23. Nov. 2001AufgelöstSekretär
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    United Kingdom
    British
    HILTON HOUSE HOTEL LIMITED28. März 2000AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    ACCOUNTANCY & ADVICE FOR SMALL BUSINESSES LIMITED05. Feb. 1999AktivManagerGeschäftsführer
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    United KingdomBritish
    C A TIMM CONTRACT SERVICES LIMITED12. Juli 200208. Nov. 2018AufgelöstSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    British
    PEAK CONTRACTS LIMITED14. März 200519. März 2018AktivSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    England
    British
    SAP DATA MIGRATORS LTD10. Juli 200615. Sept. 2016AktivSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    British
    HIGGS CAFE BAR LIMITED16. Juli 200216. Juni 2014AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    SILKTIDE LIMITED07. Feb. 200609. Mai 2014AktivSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    THE COMPASSIONATE MIND FOUNDATION26. Juli 200609. Sept. 2013AktivSecretarySekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    SAFETY REFLECTIVES LIMITED01. Okt. 200419. März 2013AufgelöstSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    United Kingdom
    British
    THE SIGN & PRINT CENTRE LIMITED30. Juni 200309. Jan. 2013AufgelöstSekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    NEXTGEN SERVERS LIMITED17. Jan. 200801. Dez. 2012AufgelöstSekretär
    11 Jackson Avenue
    DE3 9AS Derby
    Derbyshire
    British
    LLOYD AIR LIMITED09. Aug. 199930. Nov. 2012AufgelöstSecretarySekretär
    Lucre House
    108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    Derbyshire
    British
    OPTIK PROPERTIES LIMITED16. Aug. 200422. Aug. 2012AktivSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    British
    OPTIK LEISURE LIMITED15. Aug. 200222. Aug. 2012AktivSekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    British
    VICKELL PUBLICATION SERVICES LIMITED09. Aug. 199911. Mai 2012AufgelöstSecretarySekretär
    106-108 Ashbourne Road
    DE22 3AG Derby
    The Greenhouse
    Derbyshire
    United Kingdom
    British
    MAXAM UK LIMITED03. Juni 200823. Feb. 2012AktivSekretär
    11 Jackson Avenue
    DE3 9AS Derby
    Derbyshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0