Jonathan Peter Morris BIRD
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Jonathan |
| Zweites Vornamen | Peter Morris |
| Nachname | BIRD |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 0 |
| Inaktiv | 3 |
| Zurückgetreten | 14 |
| Gesamt | 17 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREHORSE ASSOCIATES LIMITED | 06. Feb. 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | New Square S40 1AH Chesterfield Dents Chambers Derbyshire England | United Kingdom | British | |
| DARLEY CONTRACTS LIMITED | 27. Okt. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | |||
| REGENERATE LIMITED | 01. Dez. 2004 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British | |
| THE COMPLETE SUITE CO LIMITED | 13. Nov. 2003 | 02. März 2017 | Aktiv | Sekretär | Salisbury Crescent Newbold S41 8PP Chesterfield 8 Derbyshire | British | ||
| BRADLEY & HOWE FINANCIAL SERVICES LIMITED | 24. Juni 2003 | 30. Juni 2008 | Aktiv | Sekretär | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | ||
| BRADLEY & HOWE FINANCIAL ASSOCIATES LIMITED | 24. Juni 2003 | 30. Juni 2008 | Aktiv | Sekretär | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | ||
| JOHN DENT (CHEMISTS) LIMITED | 13. März 2007 | 08. Apr. 2008 | Liquidation | Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| NEW SQUARE PROPERTIES LIMITED | 25. Feb. 2005 | 08. Apr. 2008 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| SAMUEL SHARP (CURRIERS) LIMITED | 21. Juni 2006 | 07. Apr. 2008 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| JCS REALISATIONS LIMITED | 21. Juni 2006 | 07. Apr. 2008 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| CLAYTON OF CHESTERFIELD LIMITED | 21. Juni 2006 | 07. Apr. 2008 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| KIRBEX LIMITED | 20. Mai 2002 | 01. Feb. 2008 | Aufgelöst | Sekretär | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | ||
| DARLEY CONTRACTS LIMITED | 15. Feb. 2005 | 26. Okt. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| REGENERATE LIMITED | 01. Dez. 2004 | 11. Feb. 2005 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | |
| I P COMMERCIAL SOLUTIONS LIMITED | 27. Juli 2002 | 07. Sept. 2002 | Aktiv | Accountant | Sekretär | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | |
| I P COMMERCIAL SOLUTIONS LIMITED | 27. Juli 2002 | 07. Sept. 2002 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| TRIO CONTRACTS LIMITED | 25. Apr. 2000 | 02. Mai 2000 | Aufgelöst | Sekretär | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0