Jonathan Peter Morris BIRD
  • Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Jonathan Peter Morris BIRD

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameJonathan
    Zweites VornamenPeter Morris
    NachnameBIRD
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv3
    Zurückgetreten14
    Gesamt17

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    FIREHORSE ASSOCIATES LIMITED06. Feb. 2015AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    New Square
    S40 1AH Chesterfield
    Dents Chambers
    Derbyshire
    England
    United KingdomBritish
    DARLEY CONTRACTS LIMITED27. Okt. 2006AufgelöstSekretär
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    British
    REGENERATE LIMITED01. Dez. 2004AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    THE COMPLETE SUITE CO LIMITED13. Nov. 200302. März 2017AktivSekretär
    Salisbury Crescent
    Newbold
    S41 8PP Chesterfield
    8
    Derbyshire
    British
    BRADLEY & HOWE FINANCIAL SERVICES LIMITED24. Juni 200330. Juni 2008AktivSekretär
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    British
    BRADLEY & HOWE FINANCIAL ASSOCIATES LIMITED24. Juni 200330. Juni 2008AktivSekretär
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    British
    JOHN DENT (CHEMISTS) LIMITED13. März 200708. Apr. 2008LiquidationAccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    NEW SQUARE PROPERTIES LIMITED25. Feb. 200508. Apr. 2008AktivAccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    SAMUEL SHARP (CURRIERS) LIMITED21. Juni 200607. Apr. 2008AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    JCS REALISATIONS LIMITED21. Juni 200607. Apr. 2008AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    CLAYTON OF CHESTERFIELD LIMITED21. Juni 200607. Apr. 2008AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    KIRBEX LIMITED20. Mai 200201. Feb. 2008AufgelöstSekretär
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    British
    DARLEY CONTRACTS LIMITED15. Feb. 200526. Okt. 2006AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    REGENERATE LIMITED01. Dez. 200411. Feb. 2005AufgelöstAccountantSekretär
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    British
    I P COMMERCIAL SOLUTIONS LIMITED27. Juli 200207. Sept. 2002AktivAccountantSekretär
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    British
    I P COMMERCIAL SOLUTIONS LIMITED27. Juli 200207. Sept. 2002AktivAccountantGeschäftsführer
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish
    TRIO CONTRACTS LIMITED25. Apr. 200002. Mai 2000AufgelöstSekretär
    76 Rectory Lane
    Breadsall Village
    DE21 5LL Derby
    Derbyshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0