Mohammad Ejaz PIRZADA
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Mohammad |
| Zweites Vornamen | Ejaz |
| Nachname | PIRZADA |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 4 |
| Inaktiv | 26 |
| Zurückgetreten | 68 |
| Gesamt | 98 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| END OF THE STREET LTD | 29. Feb. 2024 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 107 Lancefield Street G3 8HZ Glasgow 2/1 Lancefield House Scotland | Scotland | British | |
| CROSS DOWN LTD | 29. Okt. 2023 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 107 Lancefield Street G3 8HZ Glasgow 2/1 Lancefield House Scotland | Scotland | British | |
| ACROSS THE STREET LTD | 29. Okt. 2023 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 107 Lancefield Street G3 8HZ Glasgow 2/1 Lancefield House Scotland | Scotland | British | |
| DILLBACK LIMITED | 17. Aug. 2023 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 107 Lancefield Street G3 8HZ Glasgow 2/1 Lancefield House Scotland | Scotland | British | |
| DILLFLAK LIMITED | 17. Aug. 2023 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 107 Lancefield Street G3 8HZ Glasgow 2/1 Lancefield House Scotland | Scotland | British | |
| KIND OF CRISPY LTD | 20. Apr. 2022 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 United Kingdom | Scotland | British | |
| RAPSELL LTD | 08. Feb. 2022 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 United Kingdom | Scotland | British | |
| SUPERDEALZ LTD | 06. Juli 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 Scotland | Scotland | British | |
| DEAL TIME LTD | 26. Apr. 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 Scotland | Scotland | British | |
| BLUEDALE (SCOT) LTD | 20. März 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Almondvale South Almondvale Shopping Centre EH54 6HR Livingston 43a Scotland | Scotland | British | |
| ANGLE & ANGLE LTD | 20. Feb. 2018 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Milnpark Street Unit 20 G41 1BB Glasgow 22 Scotland | Scotland | British | |
| EZMOL LTD | 09. Aug. 2017 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 Scotland | Scotland | British | |
| SMART FOR YOU LTD | 29. Juni 2017 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Milnpark Street Unit 20 G41 1BB Glasgow 22 Scotland | Scotland | British | |
| ABINTOSH RETAIL LIMITED | 03. Mai 2017 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 Scotland | Scotland | British | |
| JIKTRON LIMITED | 03. Mai 2017 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 Scotland | Scotland | British | |
| UNREAL DEALS LTD | 12. Aug. 2016 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| CANDY CRUSH LTD | 09. Aug. 2016 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| C 4 CANDIES LTD | 09. Aug. 2016 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| CARD ANGELS LTD | 25. Juni 2016 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Victoria Road G42 7SA Glasgow 341 Scotland | Scotland | British | |
| NICE TASTE LTD | 22. Apr. 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| TASTE FOR EVER LTD | 16. Apr. 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Victoria Road 3/1 G42 7SA Glasgow 341 Scotland | Scotland | British | |
| SHOP AWAY LTD | 02. Apr. 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 41 Morrison Street G5 8LB Glasgow C/O Haris & Co United Kingdom | United Kingdom | British | |
| DOING FINE LTD | 08. Okt. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 41 Morrison Street G5 8LB Glasgow C/O Haris & Co United Kingdom | Scotland | British | |
| CENTRAL LANE LTD | 28. Aug. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 41 Morrison Street G5 8LB Glasgow C/O Haris & Co United Kingdom | Scotland | British | |
| WESTSHOP LIMITED | 05. Mai 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o Haris & Co Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| BEAUTY WEST LTD | 18. Jan. 2013 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o Haris & Co Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| COSMETICSWEST LTD | 07. Jan. 2013 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o Haris & Co Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| UK DISCOUNT STORES LTD | 03. Jan. 2013 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | c/o Haris & Co Morrison Street G5 8LB Glasgow 41 Scotland | Scotland | British | |
| DALEFORT LIMITED | 03. Jan. 2013 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Floor Gordon Chambers 90 Mitchell Street G1 3NQ Glasgow 6th United Kingdom | United Kingdom | British | |
| RIGGWELL LIMITED | 15. Mai 2007 | Aufgelöst | Sales Assistant | Geschäftsführer | Flat D 110 North Woodside Road G20 7DN Glasgow Strathclyde | United Kingdom | British | |
| SWEET CORNER LTD | 09. Feb. 2022 | 15. Sept. 2023 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 United Kingdom | Scotland | British |
| ALL KIND OF NUTS LTD | 08. Feb. 2022 | 15. Sept. 2023 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 United Kingdom | Scotland | British |
| CANDY CRISP LTD | 07. Okt. 2021 | 10. Juni 2022 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Sauchiehall Street G2 3AT Glasgow 113 United Kingdom | Scotland | British |
| SWEET SELECT LTD | 04. Sept. 2019 | 08. Apr. 2022 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 Scotland | Scotland | British |
| FINE & COOL LTD | 26. Apr. 2018 | 04. Feb. 2022 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 22 Milnpark Street G41 1BB Glasgow Unit 20 Scotland | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0