David John COLE
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | David |
Zweites Vornamen | John |
Nachname | COLE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 14 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 34 |
Gesamt | 49 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENT HEALTH LIMITED | 06. März 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | England | British | |
BETTER HEALTHCARE SERVICES LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
ENVIVA CARE LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
ENVIVA COMPLEX CARE LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
LIBERTATEM HEALTHCARE GROUP LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
SONDERWELL MIDCO LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
SONDERWELL FINCO LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
SONDERWELL BIDCO LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
BECC: BESPOKE COMPLEX CARE SUPPORT LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A England | England | British | |
ARROW SUPPORT LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A England | England | British | |
DIVERSITY CARE SOLUTIONS LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
LIBERTATEM HEALTHCARE HOLDINGS LTD | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
SONDERWELL TOPCO LIMITED | 01. Juli 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ground Floor Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Suite A United Kingdom | England | British | |
PICNIC TOPCO LIMITED | 01. März 2023 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Foundry Lane Milford DE56 0RN Belper Suites 1 & 5 Riverside Business Centre England | England | British | |
BAR LOMO LIMITED | 27. Nov. 2013 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Poole Road BH21 1QE Wimborne 6 Dorset United Kingdom | England | British | |
ARMADA MIDCO LIMITED | 19. Jan. 2021 | 31. Dez. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
ARMADA BIDCO LIMITED | 19. Jan. 2021 | 31. Dez. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
ARMADA TOPCO LIMITED | 19. Jan. 2021 | 31. Dez. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
VANGUARD HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED | 12. Apr. 2017 | 31. Dez. 2022 | Aktiv | Chief Executive Officer | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
PROJECT DARWIN BIDCO LIMITED | 12. Apr. 2017 | 31. Dez. 2022 | Aktiv | Chief Executive Officer | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
PROJECT DARWIN TOPCO LIMITED | 12. Apr. 2017 | 31. Dez. 2022 | Aufgelöst | Chief Executive Officer | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
VANGUARD HEALTHCARE GROUP LIMITED | 12. Apr. 2017 | 31. Dez. 2022 | Aufgelöst | Chief Executive Officer | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
VANGUARD HEALTHCARE SERVICES LIMITED | 12. Apr. 2017 | 31. Dez. 2022 | Aufgelöst | Chief Execeutive Officer | Geschäftsführer | The Square, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AD Gloucester Unit 1144 Regent Court England | England | British |
CYGNET HEALTH DEVELOPMENTS LIMITED | 27. Juni 2016 | 25. Okt. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent United Kingdom | England | British |
CYGNET HEALTH PROPERTIES LIMITED | 27. Juni 2016 | 25. Okt. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent United Kingdom | England | British |
CYGNET SURREY LIMITED | 19. Aug. 2015 | 25. Okt. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent England | England | British |
CYGNET HOSPITALS HOLDINGS LIMITED | 19. Aug. 2015 | 25. Okt. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent England | England | British |
CYGNET NW LIMITED | 19. Aug. 2015 | 25. Okt. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent England | England | British |
SAFE SPACES LIMITED | 19. Aug. 2015 | 25. Okt. 2016 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent England | England | British |
TAUNTON HOSPITAL LIMITED | 06. Feb. 2015 | 25. Okt. 2016 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent England | England | British |
ORCHARD PORTMAN HOUSE LIMITED | 06. Feb. 2015 | 25. Okt. 2016 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent England | England | British |
ORCHARD PORTMAN HOSPITAL LIMITED | 06. Feb. 2015 | 25. Okt. 2016 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | London Road Wrotham Heath TN15 7RS Sevenoaks Nepicar House Kent England | England | British |
GLENSIDE CARE GROUP LIMITED | 09. Feb. 2011 | 24. Sept. 2014 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Warminster Road South Newton SP2 0QD Salisbury Glenside Manor Wiltshire | England | British |
GLENSIDE MANOR HEALTHCARE SERVICES LIMITED | 07. März 2012 | 24. Sept. 2014 | Liquidation | Chairman | Geschäftsführer | Glenside Manor, Warminster Road South Newton SP2 0QD Salisbury Wiltshire | England | British |
CHOICE CARE GROUP HOLDINGS LIMITED | 07. Aug. 2013 | 31. März 2014 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Reading Lake Hotel Kirtons Farm Road Pingewood 2101 RG30 3ZR Reading Unit 10 Berkshire England | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0