John Stewart Richardson SWANSON
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | John |
Zweites Vornamen | Stewart Richardson |
Nachname | SWANSON |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 4 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 21 |
Gesamt | 25 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTYLIFE (BRUNTON) LIMITED | 19. Apr. 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Blagdon Estate Seaton Burn NE13 6BF Newcastle Upon Tyne 2 Wyatt Court England | England | British | |
COUNTYLIFE CORBRIDGE LIMITED | 03. Sept. 2009 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British | |
COUNTYLIFE BAMBURGH LIMITED | 03. Juli 2009 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British | |
COUNTY LIFE HOMES LIMITED | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British | ||
GREYSTOKE MORPETH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 03. Feb. 2017 | 26. Sept. 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Berwick Hill Road NE13 6BU Newcastle Upon Tyne 6 Horton Park Northumberland England | England | British |
PRINCE BISHOPS HOMES LIMITED | 10. Okt. 2014 | 18. Dez. 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Gosforth Park Avenue Gosforth Business Park NE12 8EG Newcastle Upon Tyne Number Five Great Britain | England | British |
PRINCE BISHOPS HOMES LIMITED | 10. Okt. 2014 | 10. Okt. 2014 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Amos Drive Greencroft Industrial Park DH9 7YE Stanley Greengates House County Durham | England | British |
SEAFIELD (SEAHOUSES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15. Apr. 2013 | 09. Apr. 2014 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Glanton Pyke NE66 4BB Alnwick The Hall Northumberland | England | British |
ORCHARD COURT (CORBRIDGE) MANAGEMENT LIMITED | 26. Jan. 2010 | 25. Feb. 2013 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Beaminster Way East Kingston Park NE3 2ER Newcastle Upon Tyne Cheviot House England | England | British |
MALTHOUSE MANAGEMENT ALNWICK LIMITED | 16. Apr. 2007 | 21. Dez. 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
CASTLE GARTH (BAMBURGH) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 12. Dez. 2009 | 28. Nov. 2011 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | c/o Kingston Property Services Beaminster Way East Kingston Park NE3 2ER Newcastle Upon Tyne Cheviot House England | England | British |
THE GABLES MANAGEMENT COMPANY (SHOTLEY BRIDGE) LIMITED | 05. Okt. 2006 | 29. Juli 2011 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
VIKING MANAGEMENT (SEAHOUSES) LIMITED | 24. März 2006 | 01. Okt. 2009 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
WELL STRAND (MANAGEMENT) LIMITED | 28. Feb. 2002 | 02. Juli 2008 | Aktiv | Co Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
CHRISTCHURCH MANAGEMENT (NEWCASTLE) LIMITED | 03. Aug. 2005 | 01. Sept. 2007 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
TOWN SQUARE (MANAGEMENT) LIMITED | 17. Juni 2003 | 31. Mai 2007 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
HOTSPUR MANAGEMENT LTD | 25. Feb. 2004 | 01. März 2007 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
CLOISTERS CORBRIDGE (MANAGEMENT) LIMITED | 14. Juli 2000 | 01. Mai 2003 | Aktiv | Housing Developer | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
TAY HOMES (NORTH WEST) LIMITED | 20. Aug. 1998 | 11. März 1999 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
HB (SC) LIMITED | 20. Aug. 1998 | 11. März 1999 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
TAY HOMES (MIDLANDS) LIMITED | 20. Aug. 1998 | 11. März 1999 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
HB (WX) LIMITED | 20. Aug. 1998 | 11. März 1999 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
TAY HOMES (NORTHERN) LIMITED | 20. Aug. 1998 | 11. März 1999 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
HB (CPTS) LIMITED | 24. Juli 1992 | 11. März 1999 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
JAMES HARRISON (CONTRACTS) LIMITED | 29. Juli 1991 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Hall,Glanton Pyke Glanton NE66 4BB Alnwick Northumberland England | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0