Zafer Mousa HASHIM
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Zafer |
Zweites Vornamen | Mousa |
Nachname | HASHIM |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 4 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 13 |
Gesamt | 19 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINCLAIR SUN LTD | 17. Apr. 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Sinclair Street G84 8TP Helensburgh 58 Scotland | Scotland | British | |
DSC ONLINE LTD | 11. Juni 2024 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Cross Arthurlie Street Barrhead G78 1QU Glasgow 47 Scotland | Scotland | British | |
DEEP SEA COATING LTD | 29. Mai 2024 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Cross Arthurlie Street Barrhead G78 1QU Glasgow 47 Scotland | Scotland | British | |
ZEE AND DEE LTD | 07. Feb. 2017 | Aktiv | Manager | Geschäftsführer | Bath Street G2 2SZ Glasgow 115 Scotland | Scotland | British | |
ANASTASIA + MORABITO LIMITED | 24. Feb. 2016 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Bath Street G2 2SZ Glasgow 115 | Scotland | British | |
J HENRY SHRODER & CO LIMITED | 25. Feb. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Rozelle Avenue Newton Mearns G77 6YS Glasgow 8 Scotland | Scotland | British | |
SINCLAIR SUN LTD | 31. Juli 2023 | 17. März 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Sinclair Street G84 8TP Helensburgh 58 Scotland | Scotland | British |
SINCLAIR SUN LTD | 06. Juli 2019 | 06. Juli 2019 | Aktiv | Company Secretary/Director | Geschäftsführer | Rozelle Avenue Newton Mearns G77 6YS Glasgow 8 Scotland | Scotland | British |
SINCLAIR SUN LTD | 24. Jan. 2018 | 06. März 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Sinclair Street G84 8TP Helensburgh 58 United Kingdom | Scotland | British |
SEAWARD ENTERPRISE LTD | 09. Sept. 2016 | 09. Jan. 2017 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Seaward Street G41 1HJ Glasgow 64 United Kingdom | Scotland | British |
BATMAN RIVER LIC LIMITED | 30. Dez. 2015 | 29. Jan. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Blythswood Street G2 4EG Glasgow 116 Scotland | Scotland | British |
DZH LIMITED | 17. Feb. 2015 | 29. Jan. 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 11 West Clyde Street G84 8SQ Helensburgh The Palace Restaurant Scotland | Scotland | British |
H SQUARED K LIC LIMITED | 13. Okt. 2014 | 25. Mai 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Blythswood Street G2 4EG Glasgow 116 Scotland | Scotland | British |
H-CAL LIMITED | 06. Nov. 2014 | 22. Mai 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 115 Bath Street G2 2SZ Glasgow Javid House Scotland | Scotland | British |
H SQUARED K LIMITED | 04. März 2014 | 22. Mai 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 115 Bath Street G2 2SZ Glasgow Javid House Scotland | Scotland | British |
EK ALL IN ONE LIMITED | 04. Aug. 2010 | 08. Nov. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Rozelle Avenue Newton Mearns G77 6YS Glasgow 8 Scotland | Scotland | British |
FOREST OF DEAN LIMITED | 04. Aug. 2010 | 08. Nov. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Rozelle Street Newton Mearns Glasgow 8 Scotland | Scotland | British |
NEW VERNON LIMITED | 01. Mai 2009 | 22. Apr. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Rozelle Avenue Newtonmearns G77 6YS Glasgow 8 Uk | Scotland | British |
PETITE SWEETS LIMITED | 01. Sept. 2008 | 09. März 2009 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Rozelle Avenue Newtonmearns G77 6YS Glasgow 8 Uk | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0