Colin James MACNEILL
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Colin |
| Zweites Vornamen | James |
| Nachname | MACNEILL |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 4 |
| Inaktiv | 4 |
| Zurückgetreten | 41 |
| Gesamt | 49 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETHANY CHRISTIAN TRUST | 20. Juni 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Bonnington Road EH6 5JQ Edinburgh 65 | Scotland | British | ||
| BETHANY ENTERPRISES LIMITED | 20. Juni 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Bonnington Road EH6 5JQ Edinburgh 65 | Scotland | British | ||
| THE PIPING CENTRE TRADING LIMITED | 16. Sept. 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Larkfield Gardens EH5 3QB Edinburgh 62/7 Scotland | Scotland | British | ||
| THE NATIONAL PIPING CENTRE | 30. Apr. 2018 | Aktiv | Geschäftsführer | 30-34 Mcphater Street Cowcaddens G4 0HW Glasgow | Scotland | British | ||
| COP 2018 | 01. Juni 2015 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | Scotland | British | ||
| COLLEGE OF PIPING SERVICES LIMITED | 01. Juni 2015 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 16 Otago Street Glasgow G12 8JH | Scotland | British | ||
| DMWS 981 LIMITED | 22. Aug. 2012 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 | Scotland | British | ||
| DMWSL 623 PLC | 12. Nov. 2009 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Midlothian | Scotland | British | ||
| DM CHARLOTTE SQUARE LLP | 18. Apr. 2007 | 30. Apr. 2023 | Aktiv | Mitglied der LLP | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | Scotland | ||
| 22 NOMINEES LIMITED | 30. Apr. 2001 | 30. Apr. 2023 | Aktiv | Geschäftsführer | 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF | Scotland | British | |
| DM DIRECTOR LIMITED | 30. Apr. 2001 | 30. Apr. 2023 | Aktiv | Geschäftsführer | 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF | Scotland | British | |
| 25 NOMINEES LIMITED | 30. Apr. 2001 | 30. Apr. 2023 | Aktiv | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | Scotland | British | |
| DM COMPANY SERVICES (LONDON) LIMITED | 30. Apr. 2001 | 30. Apr. 2023 | Aktiv | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | Scotland | British | |
| D M COMPANY SERVICES LIMITED | 30. Apr. 2001 | 30. Apr. 2023 | Aktiv | Geschäftsführer | 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF | Scotland | British | |
| TALKTALK MIDCO LIMITED | 09. Nov. 2020 | 09. Nov. 2020 | Aktiv | Geschäftsführer | Broadgate Tower 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13 United Kingdom | Scotland | British | |
| TALKTALK FINCO LIMITED | 09. Nov. 2020 | 09. Nov. 2020 | Aktiv | Geschäftsführer | Broadgate Tower 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13 United Kingdom | Scotland | British | |
| TALKTALK HOLDINGS LIMITED | 15. Okt. 2020 | 15. Okt. 2020 | Aktiv | Geschäftsführer | Broadgate Tower 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13 United Kingdom | Scotland | British | |
| GOODHART PARTNERS HOLDINGS LIMITED | 22. Mai 2019 | 22. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 | Scotland | British | |
| BRAMBLING HOLDINGS LIMITED | 24. Apr. 2019 | 07. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | Scotland | British | |
| WILLIAM GRANT & SONS DUFFTOWN LIMITED | 24. Apr. 2019 | 07. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 | Scotland | British | |
| CAPERCAILLIE HOLDINGS LIMITED | 24. Apr. 2019 | 07. Mai 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | Scotland | British | |
| SISKIN HOLDINGS LIMITED | 24. Apr. 2019 | 07. Mai 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 | Scotland | British | |
| STANDFAST HOLDINGS LIMITED | 24. Apr. 2019 | 07. Mai 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 | Scotland | British | |
| OSPREY HOLDINGS LIMITED | 24. Apr. 2019 | 07. Mai 2019 | Liquidation | Geschäftsführer | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 | Scotland | British | |
| DMWSL 904 LIMITED | 09. Apr. 2019 | 09. Apr. 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13, Broadgate Tower | Scotland | British | |
| TULLOW UGANDA MIDSTREAM LIMITED | 17. Aug. 2017 | 17. Aug. 2017 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 566 Chiswick High Road W4 5XT London 9 Chiswick Park | Scotland | British | |
| VELANNE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 19. Mai 2017 | 10. Juli 2017 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 1 Bruton Street W1J 6TL London Time & Life Building | Scotland | British | |
| SILCHESTER CONTINUATION LIMITED | 18. Dez. 2015 | 19. Mai 2016 | Aktiv | Geschäftsführer | 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13, Broadgate | Scotland | British | |
| TCAM ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED | 21. Sept. 2015 | 21. Sept. 2015 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13 Broadgate Tower | Scotland | British | |
| WILLIAM GRANT & SONS BRANDS LIMITED | 28. Mai 2014 | 28. Mai 2014 | Aktiv | Geschäftsführer | Primrose Street EC2A 2EW London Level 13 Broadgate Tower 20 United Kingdom | Scotland | British | |
| A.G. BARR CAPITAL PARTNER LIMITED | 26. Juni 2013 | 10. Juli 2013 | Aktiv | Geschäftsführer | 4 Mollins Road Westfield Industrial Estate G68 9HD Cumbernauld Westfield House | Scotland | British | |
| A.G. BARR GENERAL PARTNER LIMITED | 26. Juni 2013 | 10. Juli 2013 | Aktiv | Geschäftsführer | 4 Mollins Road Westfield Industrial Estate G68 9HD Cumbernauld Westfield House | Scotland | British | |
| HERBAL TEA LIMITED | 19. Dez. 2008 | 24. Dez. 2008 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 34 Garscube Terrace EH12 6BN Edinburgh Midlothian | Scotland | British | |
| ARTEMIS VCT PLC | 21. Juli 2004 | 30. Sept. 2004 | Aufgelöst | Sekretär | 34 Garscube Terrace EH12 6BN Edinburgh Midlothian | British | ||
| ARTEMIS VCT PLC | 21. Juli 2004 | 30. Sept. 2004 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 34 Garscube Terrace EH12 6BN Edinburgh Midlothian | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0