Philip James HOUNSLOW
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Philip |
Zweites Vornamen | James |
Nachname | HOUNSLOW |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 13 |
Gesamt | 15 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEGANCE YACHTS LIMITED | 24. Juni 2003 | Aufgelöst | Sekretär | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |||
ANDRATX PROPERTIES LTD | 29. Mai 2003 | Aufgelöst | Sekretär | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |||
THE GEORGE CENTRE LTD | 07. Sept. 1999 | 16. Feb. 2016 | Liquidation | Sekretär | Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Blythswood House Hampshire United Kingdom | British | ||
ADLAM MARINE LIMITED | 07. Dez. 2006 | 12. Okt. 2014 | Aufgelöst | Company Director | Sekretär | Carbery Manor Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington The Cottage Hampshire United Kingdom | British | |
ADLAM MARINE LIMITED | 23. Aug. 2011 | 26. März 2013 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | The Cottage, Carbery Manor Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington Hampshire | England | British |
ADLAM MARINE LIMITED | 07. Dez. 2006 | 30. Juni 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington The Cottage, Carbery Manor Hampshire United Kingdom | England | British |
THE GEORGE CENTRE LTD | 23. März 1999 | 01. Juni 2010 | Liquidation | Financial Director | Geschäftsführer | Adlams Lane Sway SO41 6EG Lymington The Cottage, Carbery Manor Hampshire United Kingdom | England | British |
WILLIAMS JET TENDERS LIMITED | 30. März 2005 | 01. Juni 2008 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British |
WILLIAMS JET TENDERS LIMITED | 30. März 2005 | 01. Jan. 2008 | Aktiv | Finance Director | Sekretär | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |
ALMANSA CONSTRUCTION LIMITED | 09. Juli 1996 | 23. Okt. 2003 | Aufgelöst | Financial Director | Geschäftsführer | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British |
ALMANSA CONSTRUCTION LIMITED | 09. Juli 1996 | 31. Mai 2003 | Aufgelöst | Financial Director | Sekretär | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |
PARKER BATH LIMITED | 31. Juli 1996 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British | |
PARKER BATH LIMITED | 31. Juli 1996 | Aufgelöst | Sekretär | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British | |||
THE GEORGE CENTRE LTD | 06. Apr. 1994 | 11. Jan. 1995 | Liquidation | Financial Director | Geschäftsführer | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | England | British |
THE GEORGE CENTRE LTD | 06. Apr. 1994 | 11. Jan. 1995 | Liquidation | Financial Director | Sekretär | Blythswood House Maurys Lane West Wellow SO51 6DB Romsey Hampshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0