Craig Thomas WHYTE
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Craig |
Zweites Vornamen | Thomas |
Nachname | WHYTE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 16 |
Gesamt | 18 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM DISCOUNTS PLC | 10. Nov. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Floor Aldermary House 10-15 Queen Street EC4N 1TX London 7th United Kingdom | Scotland | British | |
CAIRNWELL INVESTMENTS LIMITED | 30. Juni 2009 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British | |
LITIGATION CAPITAL LIMITED | 12. März 2013 | 29. Aug. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
MEDIA LITIGATION LIMITED | 12. März 2013 | 29. Aug. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
LAW CAPITAL LIMITED | 12. März 2013 | 29. Aug. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
LAW FINANCIAL LIMITED | 12. März 2013 | 11. Aug. 2014 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Skylines Village Limeharbour E14 9TS London 48 England | Scotland | British |
THE RANGERS FC GROUP LIMITED | 11. Feb. 2011 | 11. Apr. 2014 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bedford Row WC1R 4DF London 4 | Scotland | British |
RFC 2012 P.L.C. | 06. Mai 2011 | 01. Juni 2012 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Bedford Row WC1R 4DF London 4 England | Scotland | British |
SEVCO 5088 LIMITED | 09. Mai 2012 | 09. Mai 2012 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Grantown-On-Spey PH26 3PS Morayshire Castle Grant Scotland | Scotland | British |
SEVCO 5088 LIMITED | 09. Mai 2012 | 09. Mai 2012 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Castle Grant PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire Scotland | Scotland | British |
MERCHANT STRATEGIC RENEWAL PLC | 30. Sept. 2010 | 17. Feb. 2012 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Aldermary House 15 Queen Street EC4N 1TX London 7th Floor United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT CORPORATE RECOVERY PLC | 30. Juni 2009 | 17. Feb. 2012 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT HOUSE FINANCIAL SERVICES LIMITED | 20. Juli 2009 | 16. Dez. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
ZEMFILL PLC | 31. Aug. 2010 | 01. Sept. 2010 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Aldermary House 15 Queen Street EC4N 1TX London 7th Floor United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT INTERACTIVE LTD | 11. Sept. 2009 | 30. Apr. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
LM LOGISTICS GROUP LTD | 16. Nov. 2009 | 04. März 2010 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | Aldermary House 10-15 Queen Street EC4N 1TX London 7th Floor United Kingdom | Scotland | British |
MERCHANT TURNAROUND PLC | 05. Jan. 2010 | 01. Feb. 2010 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | PH263PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
COUNTRYLINER GROUP LTD | 04. Aug. 2009 | 14. Jan. 2010 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Castle Grant Estate PH26 3PS Grantown-On-Spey Castle Grant Morayshire United Kingdom | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0