• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Alan HAYWARD

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameAlan
    NachnameHAYWARD
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv1
    Inaktiv15
    Zurückgetreten41
    Gesamt57

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    BETTER BUSINESS PERFORMANCE LIMITED10. Okt. 2016AktivManaging DirectorGeschäftsführer
    Ellesboro Road
    B17 8PT Birmingham
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    DEFENCE EQUIPMENT SERVICES LTD11. Sept. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EAGA RENEWABLES LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    N.E.S.T.MAKERS LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EAGA DIGITAL SERVICES LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EAGA PARTNERSHIP LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    JD HEATING LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    WATERSMART LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    HORROCKS GROUP PLC22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    REAL PARTNERSHIP LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    POWERSMART LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    PROTOCOL COMMUNICATIONS MANAGEMENT LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    RESIN POLYMER APPLICATIONS LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    England
    United KingdomBritish
    EAGA DATA MANAGEMENT SERVICES LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    PROTOCOL DISTRIBUTION CENTRE LIMITED22. Jan. 2014AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SOLUTIONS IN FINANCE LIMITED03. Okt. 2011AufgelöstManaging DirectorGeschäftsführer
    Ellesboro Road
    B17 8PT Birmingham
    14
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    AMEY DEFENCE SERVICES (HOUSING) LIMITED24. Aug. 201506. Jan. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    ACM HEALTH SOLUTIONS LIMITED01. Jan. 201306. Jan. 2017AktivAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EAGA HEATING LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    84
    United KingdomBritish
    R.G. FRANCIS LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    A.F.R. LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EAGA NI LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    WARMSURE LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CARILLION HEATING SERVICES LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EAGA SERVICES LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CARILLION (ASPIRE CONSTRUCTION) LIMITED01. Jan. 201306. Jan. 2017AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CLINICENTA LIMITED28. Sept. 201506. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CARILLION HOME SERVICES LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    PME PARTNERSHIPS LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CARILLION ENERGY SERVICES SCOTLAND LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    England
    United KingdomBritish
    EAGA ENERGY SOLUTIONS LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    E.J. HORROCKS LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CARILLION ENERGY SERVICES LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    PME TECHNICAL SERVICES LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    1ST INSULATION PARTNERS LIMITED22. Jan. 201406. Jan. 2017LiquidationAccountantGeschäftsführer
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0