David James LAMONT
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | David |
Zweites Vornamen | James |
Nachname | LAMONT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 3 |
Zurückgetreten | 19 |
Gesamt | 22 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTRA LIMITED | 29. Nov. 2013 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Petre Road, Clayton Business Park Clayton Le Moors BB5 5HY Accrington 4 Lancashire England | Scotland | British | |
CARRICK HOMES LIMITED | 17. Aug. 2005 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Holywell House Prieston Road PA11 3AN Bridge Of Weir Renfrewshire | Scotland | British | |
ROZELLE HEALTHCARE LIMITED | 29. Juli 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Holywell House Prieston Road PA11 3AN Bridge Of Weir Renfrewshire | Scotland | British | |
TIMEPLAN FUEL SOLUTIONS LIMITED | 01. Mai 2018 | 22. Aug. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Clayton Business Park Clayton Le Moors BB5 5HY Accrington Unit 4 Petre Court Lancashire United Kingdom | Scotland | British |
DATA-TRACK FUEL SYSTEMS LIMITED | 29. Nov. 2013 | 22. Aug. 2022 | Aktiv | Company Director | Gesch äftsführer | Abbeymill Business Centre Seedhill PA1 1JN Paisley Suite 100 Embroidery Mill Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British |
FUELLINK SYSTEMS LTD | 28. Feb. 2022 | 03. Aug. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Capital Building 12-13 St. Andrew Square EH2 2AF Edinburgh C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Scotland | British |
FUELLINK CONTRACTS LTD | 28. Feb. 2022 | 03. Aug. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Capital Building 12-13 St. Andrew Square EH2 2AF Edinburgh C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Scotland | British |
FUELLINK HOLDINGS (SCOTLAND) LTD | 28. Feb. 2022 | 03. Aug. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Capital Building 12-13 St. Andrew Square EH2 2AF Edinburgh C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Scotland | British |
LIQUID MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | 31. Mai 2019 | 03. Aug. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Clayton Business Park Clayton Le Moors BB5 5HY Accrington Unit 4 Petre Court Lancashire England | Scotland | British |
TRISCAN SYSTEMS HOLDINGS LIMITED | 17. Apr. 2012 | 03. Aug. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Clayton Business Park Clayton Le Moors BB5 5HY Accrington Unit 4 Petre Court Lancashire United Kingdom | Scotland | British |
TRISCAN SYSTEMS LIMITED | 11. Aug. 2011 | 03. Aug. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Abbeymill Business Centre Seedhill PA1 1JN Paisley Suite 100 Embroidery Mill Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British |
SEIS (POMEGREAT) LIMITED | 24. Okt. 2011 | 05. Apr. 2013 | Aufgelöst | Company | Geschäftsführer | Abbeymill Business Centre PA1 1JN Seedmill Suite 100 Embroidery Mill Renfrewshire Uk | Scotland | British |
SYMPHONY EQUITY INVESTMENTS LIMITED | 20. Apr. 2010 | 05. Apr. 2013 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Midlothian Scotland | Scotland | British |
BOBATH SCOTLAND | 24. Apr. 2012 | 13. Sept. 2012 | Umwandlung / Auflösung | Company Director | Geschäftsführer | 10 High Craighall Road G4 9UD Glasgow Bradbury House Scotland | Scotland | British |
ENVIROTYRE LIMITED | 16. Sept. 2010 | 24. Nov. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Abbey Mill Business Centre 12 Seedhill Road PA1 1JS Paisley Suite 100 Embroidery Mill Renfrewshire | Scotland | British |
SPIERS HEALTHCARE LIMITED | 22. Jan. 2002 | 01. Nov. 2005 | Aufgelöst | Sekretär | 9 Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir Renfrewshire | British | ||
RZ HOMES LIMITED | 18. Jan. 2002 | 01. Nov. 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 9 Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir Renfrewshire | British | |
RZ HEALTHCARE LIMITED | 27. Feb. 2001 | 01. Nov. 2005 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 9 Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir Renfrewshire | British | |
RZ HOMES LIMITED | 28. Jan. 1997 | 01. Nov. 2005 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | 9 Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir Renfrewshire | British | |
SPIERS HEALTHCARE LIMITED | 27. Juni 1995 | 01. Nov. 2005 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 9 Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir Renfrewshire | British | |
VASCUTEK LIMITED | 31. Mai 2000 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 9 Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir Renfrewshire | British | ||
VASCUTEK LIMITED | 21. Sept. 1992 | Aktiv | Sekretär | 9 Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir Renfrewshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0