• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Neil John Duncan LAMONT

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameNeil
    Zweites VornamenJohn Duncan
    NachnameLAMONT
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv7
    Inaktiv18
    Zurückgetreten12
    Gesamt37

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    SPITFIRE PROPERTY HOLDINGS LIMITED08. Juli 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    5a Hospital Street
    CW5 5RH Nantwich
    Nantwich Court
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CLIFTON HOUSE SCOTLAND LLP19. Mai 2014AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    England
    STRETTON VENTURES LLP31. März 2014AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Moss Lane
    Bunbury Heath
    CW6 9SY Tarporley
    Moss Cottage
    England
    England
    WAKEFIELD ESTATES LIMITED10. März 2014AktivDirectorGeschäftsführer
    Alvaston Business Park, Middlewich Road
    CW5 6PF Nantwich
    17
    England
    EnglandBritish
    COMBINED DEVELOPMENT PARTNERSHIPS LIMITED10. März 2014AktivDirectorGeschäftsführer
    Alvaston Business Park, Middlewich Road
    CW5 6PF Nantwich
    17
    England
    EnglandBritish
    PENINA 251 LIMITED10. März 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8BD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    COMBINED DEVELOPMENT PARTNERSHIPS (WINSFORD) LIMITED10. März 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8BD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    STRETTON WAKEFIELD LIMITED02. Sept. 2013AktivDirectorGeschäftsführer
    Moss Lane
    Bunbury Heath
    CW6 9SY Tarporley
    Moss Cottage
    England
    EnglandBritish
    GLASCOED BUSINESS PARK LIMITED26. Juni 2013AufgelöstProperty ConsultantGeschäftsführer
    10 King Street
    ST5 1EL Newcastle Under Lyme
    C/O Currie Young Limited, Ground Floor
    EnglandBritish
    CLIFTON FUNDING LIMITED24. Mai 2013AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Blythswood Square
    G2 4BG Glasgow
    24
    Scotland
    EnglandBritish
    KEELE HOMES LIMITED01. Nov. 2012AktivDirectorGeschäftsführer
    Alvaston Business Park, Middlewich Road
    CW5 6PF Nantwich
    17
    England
    EnglandBritish
    COBCO 735 LIMITED20. Juni 2012AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Alvaston Business Park, Middlewich Road
    CW5 6PF Nantwich
    17
    England
    EnglandBritish
    STRETTON PALATINE (MIDDLEWICH) LIMITED12. Dez. 2011AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Moss Lane
    Bunbury Heath
    CW6 9SY Tarporley
    Moss Cottage
    England
    United KingdomBritish
    STRETTON DAIRY LLP05. Mai 2011AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    c/o Lamont Limited
    Hospital Street
    CW5 5RH Nantwich
    Nantwich Court
    Cheshire
    England
    England
    AURUM PROPERTIES LLP12. Dez. 2010AufgelöstMitglied der LLP
    c/o Lamonts
    Hospital Street
    CW5 5RH Nantwich
    Nantwich Court
    Cheshire
    England
    MARBURY TRADING COMPANY LTD07. März 2008AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Wellington Road
    CW5 7ED Nantwich
    31
    Cheshire
    EnglandBritish
    MARBURY PROPERTIES (CHESTER) LLP26. Nov. 2007AktivBestelltes Mitglied der LLP
    Moss Lane
    Beeston
    CW6 9SU Tarporley
    Moss Cottage
    England
    United Kingdom
    MARBURY PROPERTIES (GWYNEDD) LIMITED28. Sept. 2007AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Moss Lane
    Bunbury Heath
    CW6 9SY Tarporley
    Moss Cottage
    England
    United KingdomBritish
    SIGNET (OVERTON) LIMITED30. Nov. 2006AufgelöstChartered SurveyorGeschäftsführer
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8DD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    SIGNET PROPERTIES LIMITED25. Jan. 2005AufgelöstChartered SurveyorGeschäftsführer
    Coppermine Lane
    Malpas
    SY14 8BD Whitchurch
    Lilac Cottage
    Shropshire
    EnglandBritish
    BARKER COMMERCIAL LIMITED16. Nov. 2004AufgelöstSurveyorGeschäftsführer
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8BD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    EnglandBritish
    TILSTON HALL LIMITED16. Nov. 2004AufgelöstDirectorSekretär
    Alvaston Business Park Middlewich Road
    CW5 6PF Nantwich
    17
    Cheshire
    British
    LAMONT RESIDENTIAL LIMITED30. Juni 2000AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    31 Wellington Road
    Nantwich
    CW5 7ED Cheshire
    EnglandBritish
    LAMONT COMMERCIAL LIMITED30. Juni 2000AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    31 Wellington Road
    Nantwich
    CW5 7ED Cheshire
    EnglandBritish
    LAMONT LIMITED03. Aug. 1994AktivDirectorGeschäftsführer
    31 Wellington Road
    Nantwich
    CW5 7ED Cheshire
    EnglandBritish
    PEN-Y-PARC MANAGEMENT LIMITED29. Nov. 200426. Mai 2017AktivChartered SurveyorGeschäftsführer
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish
    CHESHIRE LAMONT LLP11. Feb. 201009. Sept. 2016AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Hospital Street
    CW5 5RH Nantwich
    Nantwich Court
    Cheshire
    England
    SIGNET (NANTWICH) LIMITED23. Sept. 200406. Apr. 2016AktivProperty ConsultantGeschäftsführer
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8QS Malpas
    Lilac Cottage
    Shropshire
    EnglandBritish
    NAVIGATION PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED17. Nov. 200608. Dez. 2015AktivChartered SurveyorGeschäftsführer
    Coppermine Lane
    Bickerton
    SY14 8BD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    WINSFORD 150 LIMITED23. Dez. 200916. Nov. 2015AktivChartered SurveyorGeschäftsführer
    Wellington Road
    CW5 7ED Nantwich
    31
    Cheshire
    EnglandBritish
    SOUTH CAERNARVONSHIRE YACHT CLUB LIMITED30. Apr. 201230. Aug. 2015AktivEstate AgentGeschäftsführer
    The Club House
    Abersoch
    LL53 7DP Pwllheli
    Gwynedd
    EnglandBritish
    CREAMERY INDUSTRIAL ESTATE MAINTENANCE COMPANY LIMITED01. Okt. 200901. Sept. 2014AktivEstate AgentGeschäftsführer
    Wrexham Road
    Bickerton
    SY14 8BD Malpas
    Lilac Cottage
    Cheshire
    England
    EnglandBritish
    AUDACIOUS YACHT RACING AND AVIATION LIMITED05. März 200420. Dez. 2006AufgelöstSurveyorGeschäftsführer
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish
    COCOA COURT MANAGEMENT LIMITED10. Juni 200501. März 2006AktivNoneGeschäftsführer
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish
    STRIPEMICRO LIMITED09. Mai 200309. Mai 2003AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0