• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • John BOYLE

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameJohn
    NachnameBOYLE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv4
    Inaktiv20
    Zurückgetreten38
    Gesamt62

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    HAMILTON HINDLEY PROPERTIES LTD02. Aug. 2021AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    176 St Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    The Beacon
    Scotland
    United KingdomBritish
    HCP HASI LLP01. Juli 2014AktivBestelltes Mitglied der LLP
    Mercantile Buildings, Suite 10
    53 Bothwell Street
    G2 6TS Glasgow
    C/O Hkip Llp
    Scotland
    Scotland
    NETIDME LTD10. Dez. 2012AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Nasmyth Avenue
    G75 0QR East Kilbride
    Nasmyth Building
    Scotland
    ScotlandBritish
    SIMPLE ORDERING LIMITED12. Juni 2012AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    ScotlandBritish
    WGS (HAMILTON) LLP20. Apr. 2012AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    The Aurora Building
    United Kingdom
    Scotland
    GSO HAMILTON CIP LIMITED20. Sept. 2011AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    The Beacon
    St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    176
    Scotland
    ScotlandBritish
    GLASGOW SOUTH ORBITAL (HAMILTON) LIMITED14. Sept. 2011AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    ScotlandBritish
    HAMILTON RUTHERGLEN LIMITED06. Sept. 2011AufgelöstNoneGeschäftsführer
    Ground Floor
    120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    The Aurora Building
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    HAMILTON GSO LLP26. Aug. 2011AufgelöstMitglied der LLP
    20 Renfield Street
    G2 5AP Glasgow
    Sterling House
    United Kingdom
    Scotland
    HAMILTON ORBITAL HOUSE LLP14. Sept. 2010AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    3rd Floor, 20 Renfield Street
    G2 5AP Glasgow
    Sterling House
    Scotland
    Scotland
    KELVINHAUGH LLP01. Okt. 2007AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    c/o The Hamilton Portfolio
    120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    The Aurora Building
    Scotland
    Scotland
    NEWBIGGING FARM LLP30. Sept. 2007AufgelöstMitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    United Kingdom
    Scotland
    HAMILTON ROAD DEVELOPMENTS LLP27. Juli 2007AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    United Kingdom
    Scotland
    NEWLANDSMUIR LLP01. Juli 2007AufgelöstMitglied der LLP
    Kingsborough Gardens
    G12 9NH Glasgow
    5
    Scotland
    WESTBOURNE PORTFOLIO LIMITED26. Apr. 2007AktivDirectorGeschäftsführer
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE HOLIDAY PLANNER LTD02. März 2007AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    44 Westbourne Gardens
    Kelvinside
    G12 9XQ Glasgow
    British
    ARDOCH LLP03. Nov. 2006AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    Scotland
    ZOOM AIRLINES LIMITED29. Aug. 2006AufgelöstChairmanGeschäftsführer
    44 Westbourne Gardens
    Kelvinside
    G12 9XQ Glasgow
    British
    MARYHILL DEVELOPMENTS LLP07. Juli 2005AufgelöstMitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    Scotland
    BARRANCE FARM LLP14. Apr. 2005AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    United Kingdom
    Scotland
    ELLIOT STREET DEVELOPMENTS LIMITED05. Juni 2001AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Kingsborough Gardens
    G12 9XQ Kelvinside
    5
    Glasgow
    British
    THE HAMILTON PORTFOLIO LIMITED18. Mai 1999AufgelöstEntrepeneurGeschäftsführer
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    02650075 LIMITED26. Apr. 1993LiquidationCompany DirectorGeschäftsführer
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House, 319
    ScotlandBritish
    BLACKBURN PRINT LIMITEDAktivCompany DirectorGeschäftsführer
    55 Kenilworth Square
    Rathmines
    Dublin 6
    Eire
    British
    HCP HIGH YIELD COMMERCIAL PROPERTY LLP14. Mai 201323. Feb. 2022AufgelöstMitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    Scotland
    Scotland
    ALTIA-ABM GROUP LIMITED24. Aug. 201723. Nov. 2020AktivDirectorGeschäftsführer
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    C/O Johnston Carmichael
    England
    United KingdomBritish
    ABM INTELLIGENCE LIMITED09. Aug. 201623. Nov. 2020AktivNoneGeschäftsführer
    West Regent Street
    G2 2RQ Glasgow
    146
    Scotland
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    XALTIA TECHNOLOGY LIMITED28. Mai 201423. Nov. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Altia-Abm
    Nottingham Science & Technology Park
    NG7 2RL Nottingham
    Bell House
    United KingdomBritish
    ALTIA SOLUTIONS LIMITED31. Dez. 201223. Nov. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    West Regent Street
    G2 2RQ Glasgow
    146
    Scotland
    United KingdomBritish
    BLACKFORD MEDIA LLP23. Sept. 200405. Apr. 2020AufgelöstMitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    United Kingdom
    Scotland
    OAK HOTELS LLP03. Apr. 200822. Nov. 2019AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    Rubislaw Drive
    Bearsden
    G61 1PS Glasgow
    26
    United Kingdom
    Scotland
    HINDLEY ENDURA LLP17. Sept. 201408. Aug. 2018AufgelöstMitglied der LLP
    Aurora Building
    120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    The Hamilton Portfolio
    United Kingdom
    Scotland
    THE HAMILTON PORTFOLIO PARTNERSHIP LLP19. März 201331. März 2017AktivBestelltes Mitglied der LLP
    120 Bothwell Street
    G2 7JS Glasgow
    The Aurora Building
    United Kingdom
    Scotland
    HAMILTON CAPITAL PARTNERS LLP16. März 201024. März 2017AktivMitglied der LLP
    176 St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    The Beacon
    Scotland
    HAMCAP REDHEUGHS LLP27. Jan. 201503. Feb. 2017AufgelöstBestelltes Mitglied der LLP
    176 St. Vincent Street
    G2 5SG Glasgow
    The Beacon
    Scotland

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0