John BOYLE
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | John |
Nachname | BOYLE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 4 |
Inaktiv | 20 |
Zurückgetreten | 38 |
Gesamt | 62 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAMILTON HINDLEY PROPERTIES LTD | 02. Aug. 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 176 St Vincent Street G2 5SG Glasgow The Beacon Scotland | United Kingdom | British | |
HCP HASI LLP | 01. Juli 2014 | Aktiv | Bestelltes Mitglied der LLP | Mercantile Buildings, Suite 10 53 Bothwell Street G2 6TS Glasgow C/O Hkip Llp Scotland | Scotland | |||
NETIDME LTD | 10. Dez. 2012 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Nasmyth Avenue G75 0QR East Kilbride Nasmyth Building Scotland | Scotland | British | |
SIMPLE ORDERING LIMITED | 12. Juni 2012 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Unit A1 Dolphin Way BN43 6NZ Shoreham By Sea West Sussex | Scotland | British | |
WGS (HAMILTON) LLP | 20. Apr. 2012 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building United Kingdom | Scotland | |||
GSO HAMILTON CIP LIMITED | 20. Sept. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Beacon St. Vincent Street G2 5SG Glasgow 176 Scotland | Scotland | British | |
GLASGOW SOUTH ORBITAL (HAMILTON) LIMITED | 14. Sept. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | King's Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 | Scotland | British | |
HAMILTON RUTHERGLEN LIMITED | 06. Sept. 2011 | Aufgelöst | None | Geschäftsführer | Ground Floor 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building United Kingdom | Scotland | British | |
HAMILTON GSO LLP | 26. Aug. 2011 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | 20 Renfield Street G2 5AP Glasgow Sterling House United Kingdom | Scotland | |||
HAMILTON ORBITAL HOUSE LLP | 14. Sept. 2010 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | 3rd Floor, 20 Renfield Street G2 5AP Glasgow Sterling House Scotland | Scotland | |||
KELVINHAUGH LLP | 01. Okt. 2007 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | c/o The Hamilton Portfolio 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building Scotland | Scotland | |||
NEWBIGGING FARM LLP | 30. Sept. 2007 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | |||
HAMILTON ROAD DEVELOPMENTS LLP | 27. Juli 2007 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | |||
NEWLANDSMUIR LLP | 01. Juli 2007 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | Kingsborough Gardens G12 9NH Glasgow 5 | Scotland | |||
WESTBOURNE PORTFOLIO LIMITED | 26. Apr. 2007 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | British | |
THE HOLIDAY PLANNER LTD | 02. März 2007 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 44 Westbourne Gardens Kelvinside G12 9XQ Glasgow | British | ||
ARDOCH LLP | 03. Nov. 2006 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 | Scotland | |||
ZOOM AIRLINES LIMITED | 29. Aug. 2006 | Aufgelöst | Chairman | Geschäftsführer | 44 Westbourne Gardens Kelvinside G12 9XQ Glasgow | British | ||
MARYHILL DEVELOPMENTS LLP | 07. Juli 2005 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 | Scotland | |||
BARRANCE FARM LLP | 14. Apr. 2005 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | |||
ELLIOT STREET DEVELOPMENTS LIMITED | 05. Juni 2001 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Kingsborough Gardens G12 9XQ Kelvinside 5 Glasgow | British | ||
THE HAMILTON PORTFOLIO LIMITED | 18. Mai 1999 | Aufgelöst | Entrepeneur | Geschäftsführer | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | British | |
02650075 LIMITED | 26. Apr. 1993 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House, 319 | Scotland | British | |
BLACKBURN PRINT LIMITED | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 55 Kenilworth Square Rathmines Dublin 6 Eire | British | |||
HCP HIGH YIELD COMMERCIAL PROPERTY LLP | 14. Mai 2013 | 23. Feb. 2022 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 Scotland | Scotland | ||
ALTIA-ABM GROUP LIMITED | 24. Aug. 2017 | 23. Nov. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 107-111 Fleet Street EC4A 2AB London C/O Johnston Carmichael England | United Kingdom | British |
ABM INTELLIGENCE LIMITED | 09. Aug. 2016 | 23. Nov. 2020 | Aktiv | None | Geschäftsführer | West Regent Street G2 2RQ Glasgow 146 Scotland United Kingdom | United Kingdom | British |
XALTIA TECHNOLOGY LIMITED | 28. Mai 2014 | 23. Nov. 2020 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Altia-Abm Nottingham Science & Technology Park NG7 2RL Nottingham Bell House | United Kingdom | British |
ALTIA SOLUTIONS LIMITED | 31. Dez. 2012 | 23. Nov. 2020 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | West Regent Street G2 2RQ Glasgow 146 Scotland | United Kingdom | British |
BLACKFORD MEDIA LLP | 23. Sept. 2004 | 05. Apr. 2020 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | ||
OAK HOTELS LLP | 03. Apr. 2008 | 22. Nov. 2019 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow 26 United Kingdom | Scotland | ||
HINDLEY ENDURA LLP | 17. Sept. 2014 | 08. Aug. 2018 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | Aurora Building 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Hamilton Portfolio United Kingdom | Scotland | ||
THE HAMILTON PORTFOLIO PARTNERSHIP LLP | 19. März 2013 | 31. März 2017 | Aktiv | Bestelltes Mitglied der LLP | 120 Bothwell Street G2 7JS Glasgow The Aurora Building United Kingdom | Scotland | ||
HAMILTON CAPITAL PARTNERS LLP | 16. März 2010 | 24. März 2017 | Aktiv | Mitglied der LLP | 176 St. Vincent Street G2 5SG Glasgow The Beacon | Scotland | ||
HAMCAP REDHEUGHS LLP | 27. Jan. 2015 | 03. Feb. 2017 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | 176 St. Vincent Street G2 5SG Glasgow The Beacon | Scotland |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0