• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Alan Philip CLARK

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameAlan
    Zweites VornamenPhilip
    NachnameCLARK
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv0
    Zurückgetreten43
    Gesamt43

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    BALEN IVF LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    BATH FERTILITY CENTRE LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    C HAYDEN GYNAECOLOGY LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARAMEL BIDCO LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARAMEL MIDCO LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE (SHEFFIELD) LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY (LONDON) LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY (NORTHAMPTON) LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY BIRMINGHAM LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY CHESTER (HOLDINGS) LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY CHESTER LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY GROUP LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Grant House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY HOLDINGS LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY LEEDS LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY LIVERPOOL LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY SOUTHWEST LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY TAMWORTH LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CARE FERTILITY WOKING LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CENTRE FOR REPRODUCTIVE MEDICINE LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CENTRES FOR ASSISTED REPRODUCTION LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CRGW EXETER LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CRGW GROUP LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CRGW LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    CRGW PLYMOUTH LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    IVF LIFE UK LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    RACHEL TOPCO LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    ROYTON BIDCO LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    ROYTON HOLDCO LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    ROYTON MIDCO LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    SALVE TECHNOLOGIES LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    SOUTH EAST FERTILITY CLINIC LTD28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    ZITA WEST ASSISTED FERTILITY LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    ZITA WEST CLINICS LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    MRS V. SHARMA (CONSULTANCY) LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish
    BARUSH LIMITED28. Feb. 202528. Aug. 2025AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    6 Lawrence Drive
    Nottingham Business Park
    NG8 6PZ Nottingham
    John Webster House
    England
    EnglandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0