• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Susan Mary CUMMINGS

    Natürliche Person

    TitelMs
    VornameSusan
    Zweites VornamenMary
    NachnameCUMMINGS
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv9
    Inaktiv1
    Zurückgetreten13
    Gesamt23

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    IRS OXFORD LIMITED27. Jan. 2025AktivDirectorGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    Institute Of Reproductive Sciences
    EnglandBritish
    THE BERKSHIRE CLINIC LIMITED27. Jan. 2025AktivDirectorGeschäftsführer
    8000 Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    Institute Of Reproductive Sciences
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish
    CLAREANT FERTILITY TREATMENTS LIMITED20. Nov. 2023AktivCfoGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    Institute Of Reproductive Sciences
    England
    EnglandBritish
    TFP FERTILITY GROUP LIMITED20. Nov. 2023AktivDirectorGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    Institute Of Reproductive Sciences
    England
    EnglandBritish
    TFP FERTILITY CLINICS LIMITED20. Nov. 2023AktivCfoGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    Institute Of Reproductive Sciences
    England
    EnglandBritish
    NURTURE FERTILITY LIMITED12. Okt. 2023AktivDirectorGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    8000
    England
    EnglandBritish
    THAMES VALLEY FERTILITY LIMITED12. Okt. 2023AktivDirectorGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    8000
    England
    EnglandBritish
    OXFORD FERTILITY LIMITED12. Okt. 2023AktivDirectorGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    Institute Of Reproductive Sciences
    United Kingdom
    EnglandBritish
    SIMPLY FERTILITY LTD12. Okt. 2023AktivDirectorGeschäftsführer
    Alec Issigonis Way
    Oxford Business Park North
    OX4 2HW Oxford
    Institute Of Reproductive Sciences
    United Kingdom
    EnglandBritish
    PHOENIX SURVEYING EQUIPMENT LIMITED16. Dez. 2011AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Feeder Road
    St Philips
    BS2 0TQ Bristol
    72-75
    EnglandBritish
    NURTURE LLP01. Aug. 202401. Nov. 2024AktivBestelltes Mitglied der LLP
    Bostocks Lane
    Sandiacre
    NG10 5QG Nottingham
    Interchange 25 Business Park
    England
    England
    ONE BEYOND LIMITED23. Aug. 202101. Sept. 2023AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    50-58 Victoria Road
    GU14 7PG Farnborough
    Victoria House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    DCSL MIDCO LIMITED23. Aug. 202123. Aug. 2023AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Victoria Road
    GU14 7PG Farnborough
    Victoria House
    England
    EnglandBritish
    DCSL GROUP LIMITED23. Aug. 202123. Aug. 2023AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Victoria Road
    GU14 7PG Farnborough
    Victoria House
    England
    EnglandBritish
    DCSL HOLDINGS LIMITED05. Aug. 202123. Aug. 2023AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Victoria Road
    GU14 7PG Farnborough
    Victoria House
    England
    EnglandBritish
    DCSL MANAGEMENT LIMITED05. Aug. 202123. Aug. 2023AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    50-58 Victoria Road
    GU14 7PG Farnborough
    Victoria House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    TOTAL RAIL SOLUTIONS LIMITED13. März 201930. Apr. 2021LiquidationDirectorGeschäftsführer
    Communications Road
    Greenham
    RG19 6AB Thatcham
    4
    England
    EnglandBritish
    TRACK BIDCO LIMITED23. Jan. 201930. Apr. 2021LiquidationDirectorGeschäftsführer
    Communications Road
    Greenham
    RG19 6AB Thatcham
    4
    England
    EnglandBritish
    TRACK MIDCO LIMITED23. Jan. 201930. Apr. 2021LiquidationDirectorGeschäftsführer
    Communications Road
    Greenham
    RG19 6AB Thatcham
    4
    England
    EnglandBritish
    TRACK TOPCO LIMITED23. Jan. 201930. Apr. 2021LiquidationDirectorGeschäftsführer
    Communications Road
    Greenham
    RG19 6AB Thatcham
    4
    England
    EnglandBritish
    BRANDON HIRE GROUP LIMITED22. Dez. 201109. März 2018AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    Central House Beckwith Knowle
    North Yorkshire
    EnglandBritish
    BRANDON HIRE LIMITED22. Dez. 201109. März 2018AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Beckwith Knowle
    Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish
    BRANDON HIRE GROUP HOLDINGS LIMITED16. Dez. 201109. März 2018AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Beckwith Knowle
    Otley Road
    HG3 1UD Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0