Susan Mary CUMMINGS
Natürliche Person
Titel | Ms |
---|---|
Vorname | Susan |
Zweites Vornamen | Mary |
Nachname | CUMMINGS |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 9 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 13 |
Gesamt | 23 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS OXFORD LIMITED | 27. Jan. 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford Institute Of Reproductive Sciences | England | British | |
THE BERKSHIRE CLINIC LIMITED | 27. Jan. 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 8000 Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford Institute Of Reproductive Sciences Oxfordshire England | England | British | |
CLAREANT FERTILITY TREATMENTS LIMITED | 20. Nov. 2023 | Aktiv | Cfo | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford Institute Of Reproductive Sciences England | England | British | |
TFP FERTILITY GROUP LIMITED | 20. Nov. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford Institute Of Reproductive Sciences England | England | British | |
TFP FERTILITY CLINICS LIMITED | 20. Nov. 2023 | Aktiv | Cfo | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford Institute Of Reproductive Sciences England | England | British | |
NURTURE FERTILITY LIMITED | 12. Okt. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford 8000 England | England | British | |
THAMES VALLEY FERTILITY LIMITED | 12. Okt. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford 8000 England | England | British | |
OXFORD FERTILITY LIMITED | 12. Okt. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford Institute Of Reproductive Sciences United Kingdom | England | British | |
SIMPLY FERTILITY LTD | 12. Okt. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Alec Issigonis Way Oxford Business Park North OX4 2HW Oxford Institute Of Reproductive Sciences United Kingdom | England | British | |
PHOENIX SURVEYING EQUIPMENT LIMITED | 16. Dez. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Feeder Road St Philips BS2 0TQ Bristol 72-75 | England | British | |
NURTURE LLP | 01. Aug. 2024 | 01. Nov. 2024 | Aktiv | Bestelltes Mitglied der LLP | Bostocks Lane Sandiacre NG10 5QG Nottingham Interchange 25 Business Park England | England | ||
ONE BEYOND LIMITED | 23. Aug. 2021 | 01. Sept. 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | 50-58 Victoria Road GU14 7PG Farnborough Victoria House Hampshire United Kingdom | England | British |
DCSL MIDCO LIMITED | 23. Aug. 2021 | 23. Aug. 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Victoria Road GU14 7PG Farnborough Victoria House England | England | British |
DCSL GROUP LIMITED | 23. Aug. 2021 | 23. Aug. 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Victoria Road GU14 7PG Farnborough Victoria House England | England | British |
DCSL HOLDINGS LIMITED | 05. Aug. 2021 | 23. Aug. 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | Victoria Road GU14 7PG Farnborough Victoria House England | England | British |
DCSL MANAGEMENT LIMITED | 05. Aug. 2021 | 23. Aug. 2023 | Aktiv | Chief Financial Officer | Geschäftsführer | 50-58 Victoria Road GU14 7PG Farnborough Victoria House Hampshire United Kingdom | England | British |
TOTAL RAIL SOLUTIONS LIMITED | 13. März 2019 | 30. Apr. 2021 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | Communications Road Greenham RG19 6AB Thatcham 4 England | England | British |
TRACK BIDCO LIMITED | 23. Jan. 2019 | 30. Apr. 2021 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | Communications Road Greenham RG19 6AB Thatcham 4 England | England | British |
TRACK MIDCO LIMITED | 23. Jan. 2019 | 30. Apr. 2021 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | Communications Road Greenham RG19 6AB Thatcham 4 England | England | British |
TRACK TOPCO LIMITED | 23. Jan. 2019 | 30. Apr. 2021 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | Communications Road Greenham RG19 6AB Thatcham 4 England | England | British |
BRANDON HIRE GROUP LIMITED | 22. Dez. 2011 | 09. März 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Otley Road HG3 1UD Harrogate Central House Beckwith Knowle North Yorkshire | England | British |
BRANDON HIRE LIMITED | 22. Dez. 2011 | 09. März 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British |
BRANDON HIRE GROUP HOLDINGS LIMITED | 16. Dez. 2011 | 09. März 2018 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Beckwith Knowle Otley Road HG3 1UD Harrogate Central House North Yorkshire England | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0