Thomas Michael John DILLON
Natürliche Person
| Titel | |
|---|---|
| Vorname | Thomas |
| Zweites Vornamen | Michael John |
| Nachname | DILLON |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 13 |
| Inaktiv | 0 |
| Zurückgetreten | 0 |
| Gesamt | 13 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGGHA LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Barnes Wallis Road Segensworth PO15 5TT Fareham Centurion House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| VISAVVI LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Warwick Road B11 2LE Birmingham James House United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| QUADRA AV FURNITURE LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Millfield Lane Nether Poppleton YO26 6PQ York Unit 5 England | United Kingdom | British | ||
| THE SAVILLE GROUP LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Millfield Lane Nether Poppleton YO26 6PQ York Unit 5 England | United Kingdom | British | ||
| SAVILLE AUDIO VISUAL LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Nether Poppleton YO26 6PQ York Millfield Lane North Yorkshire | United Kingdom | British | ||
| AZURE FACTORY LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Barnes Wallis Road PO15 5TT Segensworth Centurion House Hampshire England | United Kingdom | British | ||
| QUADRA CONCEPTS (UK) LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Warwick Road B11 2LE Birmingham James House United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| SEA HOLDINGS LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Warwick Road B11 2LE Birmingham James House United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| RESONATE-UCC HOLDINGS LTD | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Warwick Road Sparkhill B11 2LE Birmingham James House England | United Kingdom | British | ||
| SEA HOLDINGS (UK) LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Warwick Road B11 2LE Birmingham James House United Kingdom | United Kingdom | British | ||
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | ||
| VOHKUS LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Barnes Wallis Road PO15 5TT Segensworth Centurion House Hampshire | United Kingdom | British | ||
| E-PLENISH LIMITED | 31. Dez. 2025 | Aktiv | Geschäftsführer | Barnes Wallis Road PO15 5TT Fareham Centurion House Hampshire England | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0