• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Colette Mary GRANT

    Natürliche Person

    TitelMrs
    VornameColette
    Zweites VornamenMary
    NachnameGRANT
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv10
    Zurückgetreten18
    Gesamt28

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    ENLIGHT FOUNDATION01. Dez. 2011AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    Townhead Street
    ML3 7DP Hamilton
    Barncluith Business Centre
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    GRANT EUROPEAN FUND LIMITED15. Nov. 2007AufgelöstProperty DeveloperSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GRANT FUND MANAGEMENT LIMITED09. März 2007AufgelöstSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GLOBAL TREES PROPERTY LIMITED09. März 2007AufgelöstSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GO START A BUSINESS LIMITED23. Feb. 2007AufgelöstDirectorSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GO START A BUSINESS LIMITED23. Feb. 2007AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED06. Jan. 2006AufgelöstProperty DevelopmentGeschäftsführer
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED20. Mai 2005AufgelöstSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    GRANT CALEDONIA 2 LIMITED19. Juli 2004AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    GRANT CALEDONIA 2 LIMITED19. Juli 2004AufgelöstCompany DirectorSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION30. Jan. 201530. Juni 2024AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF Edinburgh
    13
    Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    THE ENTREPRENEURIAL EXCHANGE LIMITED03. Mai 201110. Mai 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Cathedral Street
    University Of Strathclyde Business School
    G4 0QU Glasgow
    199 - Cw6.02
    Scotland
    ScotlandBritish
    ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED07. Sept. 201722. Mai 2020AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Cathedral Street
    Strathclyde Business School
    G4 0QU Glasgow
    199
    Scotland
    ScotlandBritish
    ENTREPRENEURIAL SCOTLAND LIMITED07. Sept. 201720. Nov. 2019AktivDirectorGeschäftsführer
    Cathedral Street
    G4 0QU Glasgow
    199
    Scotland
    ScotlandBritish
    GRANT CALEDONIA LIMITED19. Apr. 200104. Nov. 2019AufgelöstProperty Development & Invest.Sekretär
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    British
    GRANT CALEDONIA LIMITED19. Apr. 200104. Nov. 2019AufgelöstProperty Development & Invest.Geschäftsführer
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    ScotlandBritish
    GP INVESTMENT & MANAGEMENT LTD17. Mai 201730. Juli 2019AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    EH3 7AF Edinburgh
    14 Coates Crescent
    Scotland
    ScotlandBritish
    SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD06. Jan. 200630. Juli 2019AktivProperty DevelopmentSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD06. Jan. 200630. Juli 2019AktivProperty DevelopmentGeschäftsführer
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    CENTRAL LETTING LIMITED13. Nov. 200330. Juli 2019AufgelöstSekretär
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    British
    CENTRAL LETTING LIMITED13. Nov. 200330. Juli 2019AufgelöstProperty DevelopmentGeschäftsführer
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF
    ScotlandBritish
    SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD19. Juni 200230. Juli 2019AktivSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD03. Mai 200130. Juli 2019AktivProperty Development InvestmenGeschäftsführer
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish
    SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD02. Juli 199830. Juli 2019LiquidationProperty Development & InvestmSekretär
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF Midlothian
    British
    SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD02. Juli 199830. Juli 2019LiquidationProperty Development & InvestmGeschäftsführer
    14 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AF Midlothian
    ScotlandBritish
    THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION15. Aug. 201715. Aug. 2017AktivDirectorGeschäftsführer
    University Of Strathclyde
    (624) 99 George Street
    G1 1RD Glasgow
    Technology & Innovation Centre
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish
    GLOBAL TREES18. Juni 200731. Mai 2017AufgelöstSekretär
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    British
    BUCCLEUCH GRANT LIMITED13. Sept. 200508. Aug. 2007AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    St. Bernards Cottage
    Mackenzie Place
    EH3 6TS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0