Colette Mary GRANT
Natürliche Person
| Titel | Mrs |
|---|---|
| Vorname | Colette |
| Zweites Vornamen | Mary |
| Nachname | GRANT |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 0 |
| Inaktiv | 10 |
| Zurückgetreten | 18 |
| Gesamt | 28 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLIGHT FOUNDATION | 01. Dez. 2011 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Townhead Street ML3 7DP Hamilton Barncluith Business Centre Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | ||
| GRANT EUROPEAN FUND LIMITED | 15. Nov. 2007 | Aufgelöst | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GRANT FUND MANAGEMENT LIMITED | 09. März 2007 | Aufgelöst | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GLOBAL TREES PROPERTY LIMITED | 09. März 2007 | Aufgelöst | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GO START A BUSINESS LIMITED | 23. Feb. 2007 | Aufgelöst | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GO START A BUSINESS LIMITED | 23. Feb. 2007 | Aufgelöst | Geschäftsführer | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | ||
| GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED | 06. Jan. 2006 | Aufgelöst | Geschäftsführer | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | ||
| GRANT RESIDENTIAL PROPERTY LIMITED | 20. Mai 2005 | Aufgelöst | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| GRANT CALEDONIA 2 LIMITED | 19. Juli 2004 | Aufgelöst | Geschäftsführer | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | ||
| GRANT CALEDONIA 2 LIMITED | 19. Juli 2004 | Aufgelöst | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | |||
| THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION | 30. Jan. 2015 | 30. Juni 2024 | Aktiv | Geschäftsführer | Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF Edinburgh 13 Lothian United Kingdom | Scotland | British | |
| THE ENTREPRENEURIAL EXCHANGE LIMITED | 03. Mai 2011 | 10. Mai 2021 | Aktiv | Geschäftsführer | Cathedral Street University Of Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 - Cw6.02 Scotland | Scotland | British | |
| ENTREPRENEURIAL SCOTLAND GROUP LIMITED | 07. Sept. 2017 | 22. Mai 2020 | Aufgelöst | Geschäftsführer | Cathedral Street Strathclyde Business School G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | |
| ENTREPRENEURIAL SCOTLAND LIMITED | 07. Sept. 2017 | 20. Nov. 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | Cathedral Street G4 0QU Glasgow 199 Scotland | Scotland | British | |
| GRANT CALEDONIA LIMITED | 19. Apr. 2001 | 04. Nov. 2019 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | British | ||
| GRANT CALEDONIA LIMITED | 19. Apr. 2001 | 04. Nov. 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | Scotland | British | |
| GP INVESTMENT & MANAGEMENT LTD | 17. Mai 2017 | 30. Juli 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | EH3 7AF Edinburgh 14 Coates Crescent Scotland | Scotland | British | |
| SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD | 06. Jan. 2006 | 30. Juli 2019 | Aktiv | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | ||
| SANDSTONE ASSET MANAGEMENT LTD | 06. Jan. 2006 | 30. Juli 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | |
| CENTRAL LETTING LIMITED | 13. Nov. 2003 | 30. Juli 2019 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | British | ||
| CENTRAL LETTING LIMITED | 13. Nov. 2003 | 30. Juli 2019 | Aufgelöst | Geschäftsführer | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF | Scotland | British | |
| SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD | 19. Juni 2002 | 30. Juli 2019 | Aktiv | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | ||
| SANDSTONE UK MANAGEMENT LTD | 03. Mai 2001 | 30. Juli 2019 | Aktiv | Geschäftsführer | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | |
| SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD | 02. Juli 1998 | 30. Juli 2019 | Liquidation | Sekretär | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF Midlothian | British | ||
| SANDSTONE UK PROPERTY INVESTMENT LTD | 02. Juli 1998 | 30. Juli 2019 | Liquidation | Geschäftsführer | 14 Coates Crescent Edinburgh EH3 7AF Midlothian | Scotland | British | |
| THE ENTREPRENEURIAL SCOTLAND FOUNDATION | 15. Aug. 2017 | 15. Aug. 2017 | Aktiv | Geschäftsführer | University Of Strathclyde (624) 99 George Street G1 1RD Glasgow Technology & Innovation Centre Scotland Scotland | Scotland | British | |
| GLOBAL TREES | 18. Juni 2007 | 31. Mai 2017 | Aufgelöst | Sekretär | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | British | ||
| BUCCLEUCH GRANT LIMITED | 13. Sept. 2005 | 08. Aug. 2007 | Aufgelöst | Geschäftsführer | St. Bernards Cottage Mackenzie Place EH3 6TS Edinburgh Midlothian | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0