Rodney John Smith BLACK
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Rodney |
Zweites Vornamen | John Smith |
Nachname | BLACK |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 29 |
Inaktiv | 13 |
Zurückgetreten | 15 |
Gesamt | 57 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC TRADING BUDE LTD | 09. Juli 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
ATLANTIC LAND BUDE LTD | 09. Juli 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
ATLANTIC HOLIDAY PARK BUDE LTD | 09. Juli 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
NEXUS SEEL STREET LTD | 01. Juli 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
FAIRWOOD LAKES HOLIDAY PARK LIMITED | 01. Juni 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant England | Scotland | British | |
FAIRWOOD LAKES LAND LTD | 01. Juni 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant England | Scotland | British | |
BEN VIEW HOLIDAY PARK LTD | 01. Juni 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
ELYSIUM RETREATS LTD | 01. Juni 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant United Kingdom | Scotland | British | |
FAIRWOOD LAKES TRADING LTD | 01. Juni 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant United Kingdom | Scotland | British | |
BEN VIEW TRADING LTD | 01. Juni 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant England | Scotland | British | |
NEXUS HOUSING DEVELOPMENTS UK LTD | 01. Juni 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
NEXUS ST MARKS CHURCH LTD | 01. Dez. 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant United Kingdom | Scotland | British | |
NEXUS GARSTON LTD | 01. Dez. 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant England | Scotland | British | |
NEXUS SORREL WAY CF LTD | 01. Dez. 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant United Kingdom | Scotland | British | |
NEXUS BROOK ROAD LTD | 01. Dez. 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant United Kingdom | Scotland | British | |
NEXUS TREASURY LTD | 01. Dez. 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant United Kingdom | Scotland | British | |
NEXUS SIMONSWOOD LTD | 01. Dez. 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
BEN VIEW LAND LTD | 11. Juli 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 United Kingdom | Scotland | British | |
BEN VIEW LODGES LTD | 11. Juli 2024 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant England | Scotland | British | |
NEXUS MAH LCH PAX LTD | 01. Juli 2024 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | CV1 2EL Coventry 5 The Quadrant United Kingdom | Scotland | British | |
LCH HOUSING LIMITED | 23. Juni 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Meadowspot EH10 5UY Edinburgh 139 Scotland | Scotland | British | |
MAH HOUSING LIMITED | 01. Juni 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Drake Street OL16 1PA Rochdale 64 England | Scotland | British | |
PAX HOUSING LIMITED | 19. Mai 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Drake Street OL16 1PA Rochdale 64 England | Scotland | British | |
LIVERPOOL COMMUNITY HOMES LIMITED | 23. Feb. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Haytor View Heathfield TQ12 6RQ Newton Abbot 4 Devon United Kingdom | Scotland | British | |
PAX APARTMENTS LIMITED | 16. Dez. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Haytor View Heathfield TQ12 6RQ Newton Abbot 4 Devon United Kingdom | Scotland | British | |
MERSEYSIDE ASSURED HOMES LIMITED | 16. Dez. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Haytor View Heathfield TQ12 6RQ Newton Abbot 4 Devon United Kingdom | Scotland | British | |
MATERIAL DEVELOPMENTS DISTRIBUTION LIMITED | 11. Jan. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Old Lennie Schoolhouse EH12 0AW Edinburgh Uk Hq Scotland | Scotland | British | |
TUSQ INTERNATIONAL LIMITED | 11. Jan. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Old Lennie Schoolhouse, EH12 0AW Edinburgh Uk Hq, United Kingdom | Scotland | British | |
MATERIAL DEVELOPMENTS LIMITED | 11. Jan. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Old Lennie Schoolhouse EH12 0AW Edinburgh Development Hq Scotland | Scotland | British | |
PROPIFI CAPITAL LTD | 04. Feb. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Quadrant CV1 2EL Coventry 5 | Scotland | British | |
SHETLAND HOLDINGS (UK) LIMITED | 29. Sept. 2014 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Blythswood Square G2 4AD Glasgow 2 United Kingdom | Scotland | British | |
GRAF SECURITIES LTD | 19. Nov. 2013 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 5th Floor Ship Canal House King Street M2 4WU Manchester C/O Clb Coopers | Scotland | British | |
GRAF SECURITIES II LIMITED | 19. Nov. 2013 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Quay 2, 139 Fountainbridge EH3 9QG Edinburgh First Floor | Scotland | British | |
ROLACK MANAGEMENT LIMITED | 08. Jan. 2013 | Aufgelöst | Managin Director | Geschäftsführer | Meadowspot EH10 5UY Edinburgh 139 United Kingdom | Scotland | British | |
9876 LIMITED | 18. Juli 2012 | Aufgelöst | Marketing Director | Geschäftsführer | c/o Bridgestones Limited Union Street OL1 1TE Oldham 125-127 Lancashire | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0