Alastair Jesse Head MACNISH
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Alastair |
Zweites Vornamen | Jesse Head |
Nachname | MACNISH |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 3 |
Zurückgetreten | 12 |
Gesamt | 15 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURLING EVENTS SCOTLAND LTD | 12. Mai 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Springkerse Business Park FK7 7XE Stirling 2a Ochil House Scotland | Scotland | British | |
THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED | 28. Sept. 2012 | Aufgelöst | Retired | Geschäftsführer | 25 Cochrane Street G1 1HL Glasgow Wheatley House Scotland | Scotland | British | |
WWCC 2005 LIMITED | 30. Juli 2004 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 23 Victoria Road PA19 1DH Gourock Renfrewshire | Scotland | British | |
WHEATLEY HOUSING GROUP LIMITED | 17. Sept. 2012 | 29. Sept. 2021 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | 25 Cochrane Street G1 1HL Glasgow Wheatley House Scotland | Scotland | British |
WHEATLEY ENTERPRISES LIMITED | 28. Sept. 2012 | 29. Sept. 2021 | Aufgelöst | Retired | Geschäftsführer | 25 Cochrane Street G1 1HL Glasgow Wheatley House Scotland | Scotland | British |
GREENOCK MEDICAL AID (PROPERTIES) LIMITED | 01. Dez. 2014 | 30. Nov. 2018 | Aktiv | Administrator | Geschäftsführer | Victoria Road PA19 1DH Gourock 23 Renfrewshire Scotland | Scotland | British |
WHEATLEY FUNDING NO. 1 LIMITED | 01. Mai 2015 | 29. Aug. 2018 | Aktiv | None | Geschäftsführer | 25 Cochrane Street G1 1HL Glasgow Wheatley House | Scotland | British |
WHEATLEY GROUP CAPITAL PLC | 13. Mai 2014 | 29. Aug. 2018 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | 25 Cochrane Street G1 1HL Glasgow Wheatley House United Kingdom | Scotland | British |
WHEATLEY FUNDING NO. 2 LIMITED | 08. Apr. 2014 | 29. Aug. 2018 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | 25 Cochrane Street G1 1HL Glasgow Wheatley House Scotland | Scotland | British |
SCOTTISH CURLING TRUST | 23. Sept. 2014 | 17. Nov. 2017 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | Victoria Road PA19 1DN Gourock 23 Renfrewshire Scotland | Scotland | British |
BRITISH CURLING | 21. Aug. 2014 | 17. Aug. 2017 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | c/o Rccc Springkerse Business Park FK7 7XE Stirling 2 Ochil House United Kingdom | Scotland | British |
THE ROYAL CALEDONIAN CURLING CLUB | 14. Juni 2014 | 17. Juni 2017 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | Victoria Road PA19 1DN Gourock 23 United Kingdom | Scotland | British |
LOWTHER HOMES LIMITED | 28. Sept. 2012 | 01. Mai 2015 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | 25 Cochrane Street G1 1HL Glasgow Wheatley House Scotland | Scotland | British |
THE GLASGOW HOUSING ASSOCIATION (FUNDING) LIMITED | 24. Sept. 2009 | 30. Sept. 2011 | Aufgelöst | Retired | Geschäftsführer | Victoria Road PA19 1DH Gourock 23 Renfrewshire | Scotland | British |
GREENOCK MEDICAL AID (PROPERTIES) LIMITED | 30. Jan. 2004 | 11. Okt. 2006 | Aktiv | Retired | Geschäftsführer | 23 Victoria Road PA19 1DH Gourock Renfrewshire | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0