Kevin BREWER - Seite 137
Natürliche Person
Titel | Dr |
---|---|
Vorname | Kevin |
Nachname | BREWER |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7377 |
Gesamt | 7384 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTTERFIELD PROPERTIES LIMITED | 30. Juni 1997 | 30. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Sekretär | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | British | ||
COIL SPRINGS LIMITED | 30. Juni 1997 | 30. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MAYBRIDGE CHEMICAL COMPANY LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
INDUSTRIAL COMPUTING LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
R.J. PRESTON LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
DANIEL'S REFRIGERATED TRANSPORT LIMITED | 27. Juni 1997 | 27. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HORNE AND MEREDITH PROPERTIES LIMITED | 26. Juni 1997 | 26. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PROFESSIONAL PIZZA COMPANY LIMITED | 26. Juni 1997 | 26. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
INTREPID ENTERPRISES LIMITED | 24. Juni 1997 | 14. Aug. 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
A.D. HYDE LIMITED | 24. Juni 1997 | 24. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
J W CONSTRUCTION CONSULTANCY LIMITED | 23. Juni 1997 | 23. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
VERALU CHIVAL LIMITED | 23. Juni 1997 | 23. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SPRITE PROJECTS LIMITED | 23. Juni 1997 | 29. Juli 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BULLET CONSULTANTS LIMITED | 23. Juni 1997 | 18. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SCOPE-EUROPE LTD | 23. Juni 1997 | 18. Juli 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PRIORITY CONTRACTS LIMITED | 23. Juni 1997 | 06. Aug. 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
STRUCOM LIMITED | 20. Juni 1997 | 20. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
STEWART BURROWS AND CO. LIMITED | 19. Juni 1997 | 30. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
KELAYS SPORT & LEISURE LIMITED | 18. Juni 1997 | 18. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
TANGLEY PARK DAY NURSERY LIMITED | 17. Juni 1997 | 17. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MAXI WASTE LIMITED | 16. Juni 1997 | 16. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SPECIALIST WATER SERVICES LIMITED | 16. Juni 1997 | 16. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
RTC NETWORKING LIMITED | 16. Juni 1997 | 16. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GENERAL MAGNETIC LIMITED | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HIGHLIGHT SERVICES LIMITED | 13. Juni 1997 | 24. Sept. 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
M.W. FASHIONS LIMITED | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ARGO PROPERTIES LIMITED | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Sekretär | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | British | ||
GORDON WEBB DEVELOPMENTS LIMITED | 13. Juni 1997 | 13. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
FLUENT EVENTS LIMITED | 12. Juni 1997 | 12. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HIGHFIELD (BIRMINGHAM) LIMITED | 12. Juni 1997 | 12. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
KINGPIN COMMUNICATIONS LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
KC & CO (COVENTRY) LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
EMPLOYEE PURCHASE FACILITY LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SHERIDAN ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
LOUP COMBLE LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0