Kevin BREWER - Seite 184
Natürliche Person
Titel | Dr |
---|---|
Vorname | Kevin |
Nachname | BREWER |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 7377 |
Gesamt | 7384 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLAND MANUFACTURING LIMITED | 27. Mai 1994 | 22. Aug. 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SOLUTION CONSULTANTS LIMITED | 27. Mai 1994 | 02. Juni 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HORSESHOES WEDDING SERVICES LTD | 27. Mai 1994 | 13. Juni 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
BOB COSTELLO ASSOCIATES LIMITED | 25. Mai 1994 | 26. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SWISSEDENT LIMITED | 24. Mai 1994 | 24. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
VINTAGE HOLDINGS LIMITED | 24. Mai 1994 | 25. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
P.C. CONSTRUCTION LIMITED | 24. Mai 1994 | 25. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
R.M. CONTRACTORS LIMITED | 23. Mai 1994 | 25. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
HOMESTEAD WINDOWS & CONSERVATORIES LIMITED | 23. Mai 1994 | 07. Juli 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
B & F (UK) LIMITED | 23. Mai 1994 | 24. Mai 1994 | Liquidation | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GENERAL SEMICONDUCTOR INDUSTRIES LIMITED | 23. Mai 1994 | 24. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
IFA LIMITED | 23. Mai 1994 | 25. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
AVRON INVESTMENTS LIMITED | 18. Mai 1994 | 05. Juli 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
POWER PRESS INSPECTION SERVICES LIMITED | 18. Mai 1994 | 19. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
AMTRAK TECHNOLOGY LIMITED | 18. Mai 1994 | 23. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
D.J LOCK & HARDWARE LIMITED | 17. Mai 1994 | 18. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
WESTLAND BARTON LIMITED | 17. Mai 1994 | 18. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
FOREST OF DEAN JALOPY CLUB LIMITED | 16. Mai 1994 | 17. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
GLOBAL EMC UK LTD | 16. Mai 1994 | 17. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
RIVCO LIMITED | 16. Mai 1994 | 17. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
WATERLOW MEWS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 16. Mai 1994 | 16. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
L & H DRIVEWAYS LIMITED | 13. Mai 1994 | 17. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
TOTAL ROOF CONTROL LIMITED | 13. Mai 1994 | 17. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PRETEC SERVICES LIMITED | 11. Mai 1994 | 12. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
EXCLUSIVE GIFTWARE LIMITED | 11. Mai 1994 | 13. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
AGRI PENNINE LIMITED | 11. Mai 1994 | 12. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
MAGUIRE ELECTRICAL SERVICES LIMITED | 11. Mai 1994 | 12. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SOL FRESH LIMITED | 09. Mai 1994 | 11. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SYNAPTIC SYSTEMS LIMITED | 05. Mai 1994 | 06. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PROPERTYWIDE SERVICES LIMITED | 05. Mai 1994 | 05. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ZENITH SUPPLIES LIMITED | 04. Mai 1994 | 18. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
SMARTCALL TECHNOLOGIES LIMITED | 03. Mai 1994 | 03. Mai 1994 | Aktiv | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
ANGLO EUROPEAN WORKFORCE LIMITED | 03. Mai 1994 | 04. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
KULAR TAILORING COMPANY LIMITED | 29. Apr. 1994 | 05. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | |
PRESTON REFRIGERATION LIMITED | 29. Apr. 1994 | 03. Mai 1994 | Aufgelöst | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British |
Zurück23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211Weiter
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0