• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Scott Keelor ANDERSON

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameScott
    Zweites VornamenKeelor
    NachnameANDERSON
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv13
    Inaktiv4
    Zurückgetreten31
    Gesamt48

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    PRIDE (SERP) LTD08. Mai 2024AktivDirectorGeschäftsführer
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Second Floor, Eagle Court 2
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE IAMP MICROGRID LIMITED06. Dez. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE PRIVATE NETWORKS HOLDCO LIMITED07. Juni 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE BTM OPERATIONAL ASSETS LIMITED22. Mai 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE DIGITAL SERVICES LIMITED27. Jan. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE IMPERIAL PARK PN LIMITED20. Dez. 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE HV ELECTRICITY ASSETS LIMITED13. Okt. 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE BTM HOLDCO LIMITED12. Okt. 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE DE SOLAR HOLDCO LIMITED22. Juni 2022AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE CONTRACTING GROUP LIMITED25. März 2021AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE HEAT NETWORKS LIMITED26. Okt. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE UTILITY SOLUTIONS LIMITED26. Okt. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE HEAT NETWORKS (BATTERSEA) LIMITED26. Okt. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    EALING LIGHTING LIMITED24. Nov. 2016AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    ISLINGTON LIGHTING LIMITED24. Nov. 2016AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SEC HIGHWAY LIGHTING DORSET LIMITED24. Nov. 2016AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    DORSET LIGHTING LIMITED24. Nov. 2016AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish
    NEWMILNS SNOW AND SPORTS COMPLEX08. Nov. 202231. Jan. 2025AktivHead Of FinanceGeschäftsführer
    High Street
    KA16 9EB Newmilns
    35
    Ayrshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    SOURCE EV UK LIMITED06. Okt. 202210. Sept. 2024AktivAccountantGeschäftsführer
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SOURCE EV LIMITED05. Aug. 202210. Sept. 2024AktivDirectorGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE EWERBY SOLAR LIMITED24. Juni 202324. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE SOUTHERY SOLAR LIMITED22. Juni 202324. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE EGGBOROUGH LIMITED16. Juni 202324. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE EWERBY SOLAR HOLDCO LIMITED16. Juni 202324. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    BY-PASS FARM SOLAR LIMITED16. Dez. 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE FIDDLERS FERRY BATTERY LIMITED14. Okt. 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE FERRYBRIDGE BATTERY LIMITED11. Okt. 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    Forbury Place
    43 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    No. 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SSE BATTERY MONK FRYSTON LIMITED03. Aug. 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE MUSKHAM SOLAR LIMITED25. Mai 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE BATTERY LIMITED25. Mai 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE SOLAR LIMITED25. Mai 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE KNAPTHORPE SOLAR LIMITED25. Mai 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE FOXHOLES SOLAR LIMITED25. Mai 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE POWER LIMITED25. Mai 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish
    SSE STAYTHORPE SGT LIMITED25. Mai 202224. Nov. 2023AktivAccountantGeschäftsführer
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0