Christopher Michael LEE
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Christopher |
Zweites Vornamen | Michael |
Nachname | LEE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 15 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 37 |
Gesamt | 52 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVILLS ASIA PACIFIC HOLDING LIMITED | 15. Feb. 2021 | Aktiv | Group Legal Director & Company Secretary | Geschäftsführer | W1G 0JD London 33 Margaret Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
SAVILLS ME LIMITED | 31. Mai 2018 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | England | British | |
SAVILLS KSA LIMITED | 31. Mai 2018 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | England | British | |
SAVILLS MIDDLE EAST HOLDINGS LIMITED | 31. Mai 2018 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | England | British | |
SAVILLS (OVERSEAS HOLDINGS) LIMITED | 23. März 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | England | British | |
CORDEA SAVILLS INVESTMENTS LIMITED | 03. Feb. 2017 | Aktiv | Company Secretary/Director | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | |
GROSVENOR HILL VENTURES LIMITED | 02. Juni 2016 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | |
SAVILLS FINANCE HOLDINGS PLC | 11. Aug. 2015 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | England | British | |
SAVILLS IM HOLDINGS LIMITED | 26. Juni 2015 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W1G 0JD London 33 Margaret Street United Kingdom | United Kingdom | British | |
SAVILLS HOLDING COMPANY LIMITED | 04. Nov. 2011 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | |
SAVILLS COMMERCIAL LIMITED | 22. Sept. 2009 | Aktiv | Sekretär | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | British | |||
SAVILLS (UK) LIMITED | 11. Sept. 2009 | Aktiv | Sekretär | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | British | |||
SAVILLS PENSION TRUST COMPANY LIMITED | 26. Sept. 2008 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | England | British | |
SAVILLS (L&P) LIMITED | 22. Aug. 2008 | Liquidation | Company Secretary | Sekretär | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | British | ||
SAVILLS PLC | 24. Juni 2008 | Aktiv | Sekretär | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | British | |||
CUREOSCITY TECHNOLOGIES LIMITED | 30. Nov. 2021 | 24. Feb. 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | W1G 0JD London 33 Margaret Street United Kingdom | United Kingdom | British |
SAVILLS LENDING SOLUTIONS LIMITED | 03. Sept. 2008 | 14. Okt. 2024 | Aufgelöst | Company Secretary | Sekretär | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | British | |
PORTNALLS LIMITED | 14. Juli 2008 | 14. Okt. 2024 | Aufgelöst | Sekretär | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | British | ||
SAVILLS IM INVESTCO LIMITED | 13. Nov. 2014 | 16. Nov. 2022 | Aktiv | Director And Company Secretary | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | United Kingdom | British |
SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | 25. Mai 2011 | 09. Dez. 2019 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 United Kingdom | England | British |
SPF PRIVATE CLIENTS LIMITED | 08. Juni 2011 | 01. Feb. 2018 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Margaret Street W1G 0JD London 33 England | England | British |
RENEWABLE CLEAN ENERGY 2 LIMITED | 08. Feb. 2011 | 05. Nov. 2011 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex United Kingdom | England | British |
SPF PRIVATE CLIENTS LIMITED | 14. Juli 2008 | 03. Mai 2011 | Aktiv | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
SHERWINS MORTGAGE SERVICES LIMITED | 14. Juli 2008 | 03. Mai 2011 | Aufgelöst | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
SAVILLS CO-INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 14. Juli 2008 | 14. Juli 2008 | Aktiv | Company Secretary | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | |
BROOKLANDS COURT (KETTERING) MANAGEMENT LIMITED | 05. März 2007 | 12. Feb. 2008 | Aktiv | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
ALFRED MCALPINE SLATE LIMITED | 01. Dez. 2005 | 12. Feb. 2008 | Aktiv | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
CAXTON HOUSE (CAMBOURNE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 17. Okt. 2005 | 12. Feb. 2008 | Aktiv | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
LODGE PARK LIMITED | 21. Apr. 2005 | 12. Feb. 2008 | Aktiv | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
HALE BROOKS LIMITED | 28. Juli 2006 | 12. Feb. 2008 | Umwandlung / Auflösung | Company Secretary | Geschäftsführer | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | England | British |
HALE BROOKS LIMITED | 28. Juli 2006 | 12. Feb. 2008 | Umwandlung / Auflösung | Company Secretary | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | |
UK POWER CONSTRUCTION LTD | 01. Dez. 2005 | 12. Feb. 2008 | Aufgelöst | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
J.F. MILLER PROPERTIES LIMITED | 01. Dez. 2005 | 12. Feb. 2008 | Aufgelöst | Chartered Secretary | Geschäftsführer | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | England | British |
POWERONLINE LIMITED | 01. Dez. 2005 | 12. Feb. 2008 | Aufgelöst | Sekretär | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | British | ||
AM SECRETARIES LIMITED | 09. Nov. 2005 | 12. Feb. 2008 | Aufgelöst | Chartered Secretary | Geschäftsführer | Mill Road CM4 9BH Stock 1 Essex | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0