Richard James MOON
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Richard |
Zweites Vornamen | James |
Nachname | MOON |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 4 |
Inaktiv | 1 |
Zurückgetreten | 34 |
Gesamt | 39 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KETECH TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | 02. Apr. 2024 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 3 Fulwood Office Park England | England | British | |
ST MICHAEL`S HOUSE (LYME REGIS) MANAGEMENT LIMITED | 11. Okt. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Southgate Commerce Park BA11 2RY Frome Unit D2 England | England | British | |
KETECH ENTERPRISES LIMITED | 05. Nov. 2015 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 3 Fulwood Office Park England | England | British | |
SYNERGIE GLOBAL LTD | 10. Mai 2012 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | Lower Castle Street BS1 3AG Bristol Begbies Tranor (Central) Llp, 3rd Floor Castlemead | England | British | |
SYNERGIE BUSINESS LIMITED | 11. Dez. 2001 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British | |
ST MICHAEL`S HOUSE (LYME REGIS) MANAGEMENT LIMITED | 18. Juni 2007 | 11. Okt. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
ADVETEC HOLDINGS LIMITED | 22. Dez. 2015 | 30. Nov. 2020 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Second Avenue Westfield BA3 4BE Radstock Unit 1 England | England | British |
PIXELPIN LTD | 12. Nov. 2015 | 15. Okt. 2020 | Aufgelöst | Chairman | Geschäftsführer | Church Road Stoke Bishop BS9 1QL Bristol Yew Tree Somerset United Kingdom | England | British |
SEVEN TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED | 02. Juli 2012 | 01. März 2019 | Aufgelöst | Company Chairman-Information Technology | Geschäftsführer | Vallis Road BA11 3EG Frome Vallis House Somerset United Kingdom | England | British |
DISCOVERIE GROUP PLC | 01. Sept. 2004 | 31. März 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 2 Chancellor Court Occam Road Surrey Research Park GU2 7AH Guildford Surrey | England | British |
SYNVEST LIMITED | 29. Aug. 2007 | 10. Jan. 2017 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
VELOCITY HOLDINGS CORPORATE TRUSTEE LIMITED | 10. Nov. 2008 | 30. Sept. 2011 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
VELOCITY ACQUISITIONS LIMITED | 28. Sept. 2006 | 30. Sept. 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
VELOCITY HOLDINGS LIMITED | 28. Sept. 2006 | 30. Sept. 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
VELOCITY INVESTCO LIMITED | 28. Sept. 2006 | 30. Sept. 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
OBS MEDICAL LIMITED | 07. Okt. 2003 | 12. Juli 2011 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
T+ MEDICAL HOLDINGS LIMITED | 17. Okt. 2005 | 01. Sept. 2010 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
T+ MEDICAL LIMITED | 21. Jan. 2004 | 17. Aug. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
KYLMAR (HOLDINGS) LIMITED | 26. Mai 2006 | 16. Juli 2009 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
SRT MARINE SYSTEMS PLC | 20. Sept. 2005 | 28. Feb. 2009 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
SECURISTYLE HOLDINGS LIMITED | 14. Apr. 2004 | 14. Dez. 2006 | Aufgelöst | Business Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
CAPITA JUSTICE & SECURE SERVICES HOLDINGS LIMITED | 01. Okt. 2003 | 25. Feb. 2005 | Liquidation | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
FLOURISH HOMES LIMITED | 09. Juni 2003 | 29. Feb. 2004 | Umwandlung / Auflösung | Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
THALES HOLDINGS UK PLC | 13. Nov. 2000 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
THALES AIR DEFENCE LIMITED | 24. Okt. 2000 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Nr Bath Avon | England | British |
THALES NAVAL LIMITED | 22. Sept. 2000 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
THALES (WEYBRIDGE) LIMITED | 28. Juli 2000 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
THALES AVIONICS LIMITED | 16. Juni 2000 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
GARRETT MOTION UK LIMITED | 31. Mai 2000 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
THALES UK LIMITED | 04. Mai 1999 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
THALES ELECTRONICS LIMITED | 10. Dez. 1998 | 21. Sept. 2001 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
STERLING FLYING TRAINING SERVICES LIMITED | 16. Juni 2000 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
THALES RESEARCH & TECHNOLOGY (UK) LIMITED | 15. Juni 2000 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
B.C.C. (SALES) LIMITED | 31. Dez. 1998 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
BRITISH COMMUNICATIONS CORPORATION LIMITED | 30. Apr. 1997 | 21. Sept. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Chestnut Barn Parsonage Lane Chilcompton BA3 4JZ Bath Avon | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0