Jane Claire STEWART
Natürliche Person
Titel | Ms |
---|---|
Vorname | Jane |
Zweites Vornamen | Claire |
Nachname | STEWART |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 3 |
Inaktiv | 5 |
Zurückgetreten | 18 |
Gesamt | 26 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 5 PLC | 01. Sept. 2023 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 44 Gutter Lane EC2V 6BR London 6th Floor, Saddlers House England | Scotland | British | |
MACPHIE LIMITED | 01. Apr. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Glenbervie AB39 3YG Stonehaven Main Office Scotland | Scotland | British | |
OFFSHORE RENEWABLE ENERGY CATAPULT | 01. März 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Albert Street NE24 1LZ Blyth Offshore House Northumberland | Scotland | British | |
WILLIAM TRACEY (DUNNIFLATS) LTD. | 11. März 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 49 Burnbrae Road Linwood Industrial E, Linwood PA3 3BD Paisley Renfrewshire | British | |||
WILLIAM TRACEY (TREARNE) LTD. | 11. März 2006 | Aufgelöst | Sekretär | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate, Linwood PA3 3BD Paisley 49 Renfrewshire Scotland | British | |||
PRN BROKERS LTD. | 11. März 2006 | Aufgelöst | Sekretär | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate, Linwood PA3 3BD Paisley 49 Renfrewshire Scotland | British | |||
HI-FLOW WASTE MANAGEMENT LIMITED | 11. März 2006 | Aufgelöst | Sekretär | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate, Linwood PA3 3BD Paisley 49 Renfrewshire Scotland | British | |||
WILLIAM TRACEY (MIDDLETON) LTD. | 11. März 2006 | Aufgelöst | Sekretär | 49 Burnbrae Road Linwood Industrial E, Linwood PA3 3BD Paisley Renfrewshire | British | |||
TOPOLYTICS LTD | 19. März 2020 | 12. Aug. 2024 | Liquidation | Business Executive | Geschäftsführer | 110 Queen Street G1 3BX Glasgow Level 8 | Scotland | British |
MANAGED IT REALISATIONS LIMITED | 21. Dez. 2016 | 30. Nov. 2022 | In Verwaltung | Director | Geschäftsführer | 54 Hareness Road AB12 3LE Aberdeen Building 54 | Scotland | British |
KCP ENVIRONMENTAL SERVICES LTD | 01. Mai 2019 | 08. Apr. 2020 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Benston Smithy KA18 4QA Cumnock The Office Scotland | Scotland | British |
ENVA RESOURCE MANAGEMENT LIMITED | 07. Aug. 2013 | 18. Sept. 2017 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Burnbrae Road PA3 3BD Linwood, Paisley 49 Renfrewshire Scotland | Scotland | British |
ENVA TIMBER RECYCLING LIMITED | 12. Juli 2006 | 18. Sept. 2017 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 49 Burnbrae Road Linwood Industrial Estate, PA3 3BD Linwood, Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
DIGIT RESOURCE MANAGEMENT HOLDINGS LTD | 07. Aug. 2013 | 18. Sept. 2017 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Burnbrae Road PA3 3BD Linwood, Paisley 49 Renfrewshire Scotland | Scotland | British |
TANK CLEANING SERVICES LIMITED | 05. Dez. 2009 | 18. Sept. 2017 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Nest Road Gateshead NE10 0ES Tyne And Wear | Scotland | British |
INDUSTRIAL & MUNICIPAL PROJECTS LIMITED | 12. Juni 2009 | 18. Sept. 2017 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate PA3 3BD Linwood 49 Renfrewshire Uk | Scotland | British |
RECYCLING SOLUTIONS LIMITED | 09. Juli 2008 | 18. Sept. 2017 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate PA3 3BD Linwood 49 | Scotland | British |
RECYCLING SOLUTIONS LIMITED | 09. Juli 2008 | 18. Sept. 2017 | Aufgelöst | Director | Sekretär | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate PA3 3BD Linwood 49 | British | |
ENVA SCOTLAND LIMITED | 06. Sept. 2005 | 15. Sept. 2017 | Aktiv | Chartered Accountant | Sekretär | 49 Burnbrae Road Linwood PA3 3BD Paisley Renfrewshire | British | |
ENVA SCOTLAND LIMITED | 06. Sept. 2005 | 15. Sept. 2017 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 49 Burnbrae Road Linwood PA3 3BD Paisley Renfrewshire | Scotland | British |
ENVA TIMBER RECYCLING LIMITED | 06. Sept. 2005 | 07. Sept. 2017 | Aktiv | Sekretär | 49 Burnbrae Road Linwood Industrial Estate, PA3 3BD Linwood, Paisley Renfrewshire | British | ||
INDUSTRIAL & MUNICIPAL PROJECTS LIMITED | 11. Jan. 2008 | 07. Sept. 2017 | Aufgelöst | Sekretär | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate PA3 3BD Linwood 49 Renfrewshire Uk | British | ||
MCDONALD RECYCLING LIMITED | 11. März 2006 | 07. Sept. 2017 | Aufgelöst | Sekretär | Burnbrae Road Linwood Industrial Estate, Linwood PA3 3BD Paisley 49 Renfrewshire Scotland | British | ||
WILLIAM TRACEY (PROJECTS) LTD. | 06. Sept. 2005 | 07. Sept. 2017 | Aufgelöst | Sekretär | 49 Burnbrae Road Linwood Industrial Estate PA3 3BD Linwood Renfrewshire | British | ||
SCOTTISH EPILEPSY INITIATIVE | 24. Nov. 2011 | 08. Jan. 2016 | Aufgelöst | Chartered Accountant | Geschäftsführer | St Thomas's Well FK7 9PR Stirling St Thomas's Well House Scotland | Scotland | British |
ALLGLASS REPROCESSORS (U.K.) LIMITED | 06. Sept. 2005 | 02. Feb. 2009 | Aktiv | Sekretär | 6 Abbey View FK9 5JZ Stirling Stirlingshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0