• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Jane Claire STEWART

    Natürliche Person

    TitelMs
    VornameJane
    Zweites VornamenClaire
    NachnameSTEWART
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv3
    Inaktiv5
    Zurückgetreten18
    Gesamt26

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 5 PLC01. Sept. 2023AktivDirectorGeschäftsführer
    44 Gutter Lane
    EC2V 6BR London
    6th Floor, Saddlers House
    England
    ScotlandBritish
    MACPHIE LIMITED01. Apr. 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    Glenbervie
    AB39 3YG Stonehaven
    Main Office
    Scotland
    ScotlandBritish
    OFFSHORE RENEWABLE ENERGY CATAPULT01. März 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    Albert Street
    NE24 1LZ Blyth
    Offshore House
    Northumberland
    ScotlandBritish
    WILLIAM TRACEY (DUNNIFLATS) LTD.11. März 2006AufgelöstSekretär
    49 Burnbrae Road
    Linwood Industrial E, Linwood
    PA3 3BD Paisley
    Renfrewshire
    British
    WILLIAM TRACEY (TREARNE) LTD.11. März 2006AufgelöstSekretär
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate, Linwood
    PA3 3BD Paisley
    49
    Renfrewshire
    Scotland
    British
    PRN BROKERS LTD.11. März 2006AufgelöstSekretär
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate, Linwood
    PA3 3BD Paisley
    49
    Renfrewshire
    Scotland
    British
    HI-FLOW WASTE MANAGEMENT LIMITED11. März 2006AufgelöstSekretär
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate, Linwood
    PA3 3BD Paisley
    49
    Renfrewshire
    Scotland
    British
    WILLIAM TRACEY (MIDDLETON) LTD.11. März 2006AufgelöstSekretär
    49 Burnbrae Road
    Linwood Industrial E, Linwood
    PA3 3BD Paisley
    Renfrewshire
    British
    TOPOLYTICS LTD19. März 202012. Aug. 2024LiquidationBusiness ExecutiveGeschäftsführer
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Level 8
    ScotlandBritish
    MANAGED IT REALISATIONS LIMITED21. Dez. 201630. Nov. 2022In VerwaltungDirectorGeschäftsführer
    54 Hareness Road
    AB12 3LE Aberdeen
    Building 54
    ScotlandBritish
    KCP ENVIRONMENTAL SERVICES LTD01. Mai 201908. Apr. 2020AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Benston Smithy
    KA18 4QA Cumnock
    The Office
    Scotland
    ScotlandBritish
    ENVA RESOURCE MANAGEMENT LIMITED07. Aug. 201318. Sept. 2017AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Burnbrae Road
    PA3 3BD Linwood, Paisley
    49
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish
    ENVA TIMBER RECYCLING LIMITED12. Juli 200618. Sept. 2017AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    49 Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate,
    PA3 3BD Linwood, Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish
    DIGIT RESOURCE MANAGEMENT HOLDINGS LTD07. Aug. 201318. Sept. 2017AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    Burnbrae Road
    PA3 3BD Linwood, Paisley
    49
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish
    TANK CLEANING SERVICES LIMITED05. Dez. 200918. Sept. 2017AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    Nest Road
    Gateshead
    NE10 0ES Tyne And Wear
    ScotlandBritish
    INDUSTRIAL & MUNICIPAL PROJECTS LIMITED12. Juni 200918. Sept. 2017AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate
    PA3 3BD Linwood
    49
    Renfrewshire
    Uk
    ScotlandBritish
    RECYCLING SOLUTIONS LIMITED09. Juli 200818. Sept. 2017AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate
    PA3 3BD Linwood
    49
    ScotlandBritish
    RECYCLING SOLUTIONS LIMITED09. Juli 200818. Sept. 2017AufgelöstDirectorSekretär
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate
    PA3 3BD Linwood
    49
    British
    ENVA SCOTLAND LIMITED06. Sept. 200515. Sept. 2017AktivChartered AccountantSekretär
    49 Burnbrae Road
    Linwood
    PA3 3BD Paisley
    Renfrewshire
    British
    ENVA SCOTLAND LIMITED06. Sept. 200515. Sept. 2017AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    49 Burnbrae Road
    Linwood
    PA3 3BD Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish
    ENVA TIMBER RECYCLING LIMITED06. Sept. 200507. Sept. 2017AktivSekretär
    49 Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate,
    PA3 3BD Linwood, Paisley
    Renfrewshire
    British
    INDUSTRIAL & MUNICIPAL PROJECTS LIMITED11. Jan. 200807. Sept. 2017AufgelöstSekretär
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate
    PA3 3BD Linwood
    49
    Renfrewshire
    Uk
    British
    MCDONALD RECYCLING LIMITED11. März 200607. Sept. 2017AufgelöstSekretär
    Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate, Linwood
    PA3 3BD Paisley
    49
    Renfrewshire
    Scotland
    British
    WILLIAM TRACEY (PROJECTS) LTD.06. Sept. 200507. Sept. 2017AufgelöstSekretär
    49 Burnbrae Road
    Linwood Industrial Estate
    PA3 3BD Linwood
    Renfrewshire
    British
    SCOTTISH EPILEPSY INITIATIVE24. Nov. 201108. Jan. 2016AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    St Thomas's Well
    FK7 9PR Stirling
    St Thomas's Well House
    Scotland
    ScotlandBritish
    ALLGLASS REPROCESSORS (U.K.) LIMITED06. Sept. 200502. Feb. 2009AktivSekretär
    6 Abbey View
    FK9 5JZ Stirling
    Stirlingshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0