Steven DAVIES
Natürliche Person
| Titel | Mr |
|---|---|
| Vorname | Steven |
| Nachname | DAVIES |
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein |
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 |
| Inaktiv | 16 |
| Zurückgetreten | 6 |
| Gesamt | 23 |
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGHT PROMOTIONS LIMITED | 01. Sept. 2022 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services United Kingdom | England | British | |
| CINCO CHEMICAL SOLUTIONS LIMITED | 23. Juli 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Longbeck Estate TS11 6HR Marske-By-The-Sea Lexington Building England | England | British | |
| DRIVEWAY SOLUTIONS DIRECT LTD | 20. Juli 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services England | England | British | |
| CHEM-CLEAN UK LTD | 15. Apr. 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services England | England | British | |
| ANGEMAX TRADING CO LTD | 04. Apr. 2019 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services England | England | British | |
| THE COCKTAIL LOUNGE LTD | 11. Mai 2018 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services England | England | British | |
| OIL & GAS CONTACTS LIMITED | 30. März 2015 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Selby Road LS15 4LG Leeds Carrwood Park | England | British | |
| DRINKS TO GO (NE) LTD | 12. Aug. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | First Floor, Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Cleveland England | England | British | |
| THIRSTY (NE) LTD | 12. Aug. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | First Floor, Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Cleveland England | England | British | |
| CONCERT DRINKERS LTD | 15. Mai 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | First Floor, Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Cleveland England | England | British | |
| BEACH DRINKERS LTD | 14. Mai 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | First Floor, Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Cleveland England | England | British | |
| LOOSE CANNON LIVE LTD | 21. März 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | First Floor, Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Cleveland England | England | British | |
| POWER BRANDS (UK) LTD | 03. Sept. 2013 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | First Floor, Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Cleveland England | England | British | |
| THE LIFESTYLE DISCOUNT CARD LIMITED | 22. Nov. 2011 | Aufgelöst | Landlord | Geschäftsführer | The Innovation Centre Vienna Court Kirkleatham Business Park TS10 5SH Redcar Unit 306 United Kingdom | England | British | |
| THE LIFESTYLE VIP COMPANY LIMITED | 22. Nov. 2011 | Aufgelöst | Landlord | Geschäftsführer | The Innovation Centre Vienna Court Kirkleatham Business Park TS10 5SH Redcar Unit 306 United Kingdom | England | British | |
| POWER TRADE LIMITED | 26. Jan. 2006 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Cleveland England | England | British | |
| PORTLAND DEVELOPMENTS (NORTH EAST) LIMITED | 15. Apr. 2005 | Aktiv | Land Sales | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services England | England | British | |
| UPEX PIES LIMITED | 11. Okt. 2022 | 10. Jan. 2024 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | First Floor , Enterprise House 202 - 206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services Cleveland | England | British |
| CINCO CHEMICALS LTD | 31. Mai 2021 | 31. Mai 2022 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Services England | England | British |
| SKYLIVE AIR LTD | 23. Sept. 2019 | 10. Mai 2022 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 1st Floor Enterprise House 202-206 Linthorpe Road TS1 3QW Middlesbrough Beaumont Accountancy Acountancy England | England | British |
| PURE-HEAL LTD | 28. Feb. 2020 | 05. Apr. 2021 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Hall Drive TS5 7DY Acklam Acklam Hall England | England | British |
| SKYLIVE EVENTS LTD | 09. Okt. 2014 | 09. Okt. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Vienna Court Kirkleatham Business Park TS10 5SH Redcar 306 Innovation Centre Cleveland England | England | British |
| TRADE HOME IMPROVEMENTS LIMITED | 11. Jan. 2008 | 01. Sept. 2009 | Aufgelöst | Home Improvements | Geschäftsführer | 9 Phillips Avenue TS5 5PP Middlesbrough Cleveland | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0