• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Steven DAVIES

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameSteven
    NachnameDAVIES
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv1
    Inaktiv16
    Zurückgetreten6
    Gesamt23

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    RIGHT PROMOTIONS LIMITED01. Sept. 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CINCO CHEMICAL SOLUTIONS LIMITED23. Juli 2021AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Longbeck Estate
    TS11 6HR Marske-By-The-Sea
    Lexington Building
    England
    EnglandBritish
    DRIVEWAY SOLUTIONS DIRECT LTD20. Juli 2020AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    England
    EnglandBritish
    CHEM-CLEAN UK LTD15. Apr. 2020AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    England
    EnglandBritish
    ANGEMAX TRADING CO LTD04. Apr. 2019AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    England
    EnglandBritish
    THE COCKTAIL LOUNGE LTD11. Mai 2018AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    England
    EnglandBritish
    OIL & GAS CONTACTS LIMITED30. März 2015AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Selby Road
    LS15 4LG Leeds
    Carrwood Park
    EnglandBritish
    DRINKS TO GO (NE) LTD12. Aug. 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    First Floor, Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    THIRSTY (NE) LTD12. Aug. 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    First Floor, Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    CONCERT DRINKERS LTD15. Mai 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    First Floor, Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    BEACH DRINKERS LTD14. Mai 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    First Floor, Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    LOOSE CANNON LIVE LTD21. März 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    First Floor, Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    POWER BRANDS (UK) LTD03. Sept. 2013AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    First Floor, Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    THE LIFESTYLE DISCOUNT CARD LIMITED22. Nov. 2011AufgelöstLandlordGeschäftsführer
    The Innovation Centre
    Vienna Court Kirkleatham Business Park
    TS10 5SH Redcar
    Unit 306
    United Kingdom
    EnglandBritish
    THE LIFESTYLE VIP COMPANY LIMITED22. Nov. 2011AufgelöstLandlordGeschäftsführer
    The Innovation Centre
    Vienna Court Kirkleatham Business Park
    TS10 5SH Redcar
    Unit 306
    United Kingdom
    EnglandBritish
    POWER TRADE LIMITED26. Jan. 2006AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    PORTLAND DEVELOPMENTS (NORTH EAST) LIMITED15. Apr. 2005AktivLand SalesGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    England
    EnglandBritish
    UPEX PIES LIMITED11. Okt. 202210. Jan. 2024AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    First Floor , Enterprise House
    202 - 206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    Cleveland
    EnglandBritish
    CINCO CHEMICALS LTD31. Mai 202131. Mai 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Services
    England
    EnglandBritish
    SKYLIVE AIR LTD23. Sept. 201910. Mai 2022AufgelöstCompany DirectorGeschäftsführer
    1st Floor Enterprise House
    202-206 Linthorpe Road
    TS1 3QW Middlesbrough
    Beaumont Accountancy Acountancy
    England
    EnglandBritish
    PURE-HEAL LTD28. Feb. 202005. Apr. 2021AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Hall Drive
    TS5 7DY Acklam
    Acklam Hall
    England
    EnglandBritish
    SKYLIVE EVENTS LTD09. Okt. 201409. Okt. 2014AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Vienna Court
    Kirkleatham Business Park
    TS10 5SH Redcar
    306 Innovation Centre
    Cleveland
    England
    EnglandBritish
    TRADE HOME IMPROVEMENTS LIMITED11. Jan. 200801. Sept. 2009AufgelöstHome ImprovementsGeschäftsführer
    9 Phillips Avenue
    TS5 5PP Middlesbrough
    Cleveland
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0