Catherine Helen MOGER
Natürliche Person
Titel | Mrs |
---|---|
Vorname | Catherine |
Zweites Vornamen | Helen |
Nachname | MOGER |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 9 |
Gesamt | 16 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW LADE LTD | 21. Mai 2018 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Mallard Road Bretton PE3 8@AF Peterborough Marmlade House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
MARMALADE FOUNDATION COMMUNITY INTEREST COMPANY | 03. Sept. 2013 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Semley Road SP7 9HE Shaftesbury Thanes House England | United Kingdom | British | |
INTELLIGENT LADE LTD | 19. Mai 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Mallard Road Bretton PE3 8AF Peterborough Marmalade House, Alpha Business Centre Cambridgeshire England | United Kingdom | British | |
YMPM GROUP LIMITED | 17. Jan. 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Yeovil Road Tintinhull BA22 8QL Yeovil 11 Somerset England | United Kingdom | British | |
BABCO FUEL AND ENERGY LTD | 14. Okt. 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Yeovil Road Tintinhull BA22 8QL Yeovil 11 Somerset Uk | United Kingdom | British | |
LONGTHORPE INVESTMENTS LIMITED | 03. Juni 2009 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Greatlands House Little Raveley PE28 2NQ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | |
BABCO ENERGY LIMITED | 22. Aug. 2008 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Greatlands House Little Raveley PE28 2NQ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | |
MARMALADE NETWORK LTD | 03. Okt. 2016 | 31. März 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Nile Street ST6 2BA Stoke-On-Trent Autonet Insurance England | United Kingdom | British |
MARMALADE LTD | 04. Sept. 2013 | 31. März 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Mallard Road Bretton PE3 8AF Peterborough Marmalade House, Alpha Business Centre Cambridgeshire England | United Kingdom | British |
MARMALADE LEASING LIMITED | 31. Dez. 2007 | 31. März 2021 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Nile Street ST6 2BA Stoke-On-Trent Autonet Insurance England | United Kingdom | British |
YOUNG MARMALADE LIMITED | 19. Apr. 2007 | 31. März 2021 | Aktiv | Sekretär | Nile Street ST6 2BA Stoke-On-Trent Autonet Insurance England | British | ||
YOUNG MARMALADE LIMITED | 03. Apr. 2007 | 31. März 2021 | Aktiv | Manager | Geschäftsführer | Nile Street ST6 2BA Stoke-On-Trent Autonet Insurance England | United Kingdom | British |
NEW LADE LTD | 21. Mai 2018 | 21. Mai 2018 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Mallard Road Bretton PE3 8AF Peterborough Marmalade House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British |
PAINFREEWALKING LTD | 19. Juni 2008 | 11. Jan. 2012 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Greatlands House Little Raveley PE28 2NQ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British |
SIRIUS DISTRIBUTION LTD | 01. Apr. 2010 | 07. Jan. 2012 | Aktiv | None | Geschäftsführer | 11 Yeovil Road Tintinhull BA22 8QL Yeovil Bowdene House Somerset | United Kingdom | British |
JH SEED TRIALS LIMITED LIMITED | 29. Nov. 2010 | 31. Aug. 2011 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Yeovil Road Tintinhull BA22 8QL Yeovil 11 Somerset England | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0