Mark Ian DE ROZARIEUX
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Mark |
Zweites Vornamen | Ian |
Nachname | DE ROZARIEUX |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 7 |
Inaktiv | 3 |
Zurückgetreten | 22 |
Gesamt | 32 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMS HOLIDAYS LIMITED | 23. Feb. 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Bar Road DE45 1SF Baslow Ladywell House Derbyshire United Kingdom | England | British | |
ITAC LIMITED | 04. Feb. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Chapel-En-Le-Frith SK23 0HW High Peak High Peak Works Derbyshire England | England | British | |
DELVEMADE LIMITED | 04. Feb. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Chapel-En-Le-Frith SK23 0HW High Peak High Peak Works Derbyshire England | England | British | |
SEAMSIL LIMITED | 04. Feb. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Chapel-En-Le-Frith SK23 0HW High Peak High Peak Works Derbyshire England | England | British | |
H.D.SHARMAN LIMITED | 24. Mai 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Flemming Court Whistler Drive WF10 5HW Castleford 13 West Yorkshire England | England | British | |
HD SHARMAN GROUP LIMITED | 07. Nov. 2017 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Chapel-En-Le-Frith SK23 0HW High Peak High Peak Works Derbyshire United Kingdom | England | British | |
FANCY STUFF LIMITED | 05. Mai 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Bar Road DE45 1SF Baslow Ladywell House Derbyshire United Kingdom | England | British | |
ARCHITECTURAL CONSTRUCTION PRODUCTS LIMITED | 12. Juli 2010 | Aufgelöst | Finance Director | Geschäftsführer | Southwick Industrial Estate North Hylton Road SR5 3TX Sunderland Former Federal Mogul Building Tyne And Wear England | England | British | |
TOOTH FAIRY LIMITED | 23. Mai 2003 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British | |
TOOTH FAIRY LIMITED | 23. Mai 2003 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | ||
BOSCOMBE FORGE LTD | 06. Nov. 2020 | 01. Feb. 2022 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Bar Road DE45 1SF Baslow Ladywell House Derbyshire England | England | British |
TIMBER WINDOWS.COM LIMITED | 06. Nov. 2007 | 24. Nov. 2014 | Aktiv | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | ||
TIMBER WINDOWS.COM LIMITED | 06. Nov. 2007 | 24. Nov. 2014 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
PERFORMANCE TIMBER PRODUCTS GROUP LIMITED | 19. Feb. 2009 | 24. März 2014 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
MUMFORD & WOOD LIMITED | 01. Nov. 2006 | 24. März 2014 | Aktiv | Director | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | |
MUMFORD & WOOD LIMITED | 01. Nov. 2006 | 24. März 2014 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
THE PERFORMANCE WINDOW GROUP LIMITED | 30. Okt. 2006 | 24. März 2014 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
THE PERFORMANCE WINDOW GROUP LIMITED | 30. Okt. 2006 | 24. März 2014 | Aktiv | Finance Director | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | |
PWG TRADING LIMITED | 19. Feb. 2009 | 26. Feb. 2014 | Aktiv | Director/Secretary | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
PERFORMANCE TIMBER PRODUCTS GROUP LIMITED | 02. Feb. 2009 | 19. Feb. 2009 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
SIG DORMANT COMPANY NUMBER ELEVEN LIMITED | 16. Dez. 2003 | 19. Apr. 2007 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
SIG DORMANT COMPANY NUMBER TEN LIMITED | 16. Dez. 2003 | 01. Dez. 2006 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
LEADERFLUSH + SHAPLAND HOLDINGS LIMITED | 16. Dez. 2003 | 01. Dez. 2006 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
SIG MANUFACTURING LIMITED | 16. Dez. 2003 | 01. Dez. 2006 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
SIG DORMANT COMPANY NUMBER ELEVEN LIMITED | 16. Dez. 2003 | 27. Juli 2006 | Aktiv | Accountant | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | |
SIG DORMANT COMPANY NUMBER TEN LIMITED | 16. Dez. 2003 | 24. Juni 2005 | Aktiv | Accountant | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | |
LEADERFLUSH + SHAPLAND HOLDINGS LIMITED | 16. Dez. 2003 | 24. Juni 2005 | Aktiv | Accountant | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | |
SIG MANUFACTURING LIMITED | 16. Dez. 2003 | 24. Juni 2005 | Aktiv | Accountant | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | |
PARK LANE (FOODS) LIMITED | 02. Apr. 2002 | 30. Sept. 2003 | Aufgelöst | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | ||
MATTHEWS FOODS LIMITED | 26. Juni 2002 | 23. Sept. 2003 | Aktiv | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | ||
ZUBRANCE LIMITED | 19. Dez. 2001 | 23. Sept. 2003 | Aktiv | Sekretär | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | British | ||
LEVIAT LIMITED | 06. Nov. 2000 | 30. Apr. 2002 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Ladywell House Bar Road DE45 1SF Baslow Derbyshire | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0