Sean Edward RICE
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Sean |
Zweites Vornamen | Edward |
Nachname | RICE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 15 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 0 |
Gesamt | 15 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXFORD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING LIMITED | 12. Juli 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Mackenzie Way Swindon Village GL51 9TX Cheltenham 1 Manor Park Business Centre England | England | British | |
PENTWIN INVESTMENTS LIMITED | 12. Juli 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Manor Park Business Centre Mackenzie Way GL51 9TX Cheltenham 1 Gloucestershire | England | British | |
HARDMETAL ENGINEERING (CORNWALL) LIMITED | 12. Juli 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Treleigh Industrial Estate TR16 4AX Redruth Unit 3 Jon Davey Drive Cornwall England | England | British | |
SPRINT TOOL AND DIE LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Stafford Park 12 TF3 3BJ Telford Unit 1 Shropshire England | England | British | |
MCALPINE GRANT ILCO LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Mackenzie Way Swindon Village GL51 9TX Cheltenham 1 Manor Park Business Centre Gloucestershire | England | British | |
ILCO REFRIGERATION LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Mackenzie Way Swindon Village GL51 9TX Cheltenham 1 Manor Park Business Centre Gloucestershire England | England | British | |
R J P REFRIGERATION CONTRACTORS LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Mackenzie Way Swindon Village GL51 9TX Cheltenham 1 Manor Park Business Centre Gloucestershire England | England | British | |
SUBFRAMES UK LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 2-4 Sawpit Industrial Estate Tibshelf DE55 5NH Alfreton Derbyshire | England | British | |
BC CAR PARTS LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Treleigh Industrial Estate TR16 4AX Redruth Unit 3 Jon Davey Drive Cornwall England | England | British | |
TRELEIGH HOLDINGS LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Treleigh Industrial Estate TR16 4AX Redruth Unit 3 Jon Davey Drive Cornwall England | England | British | |
WES ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Treleigh Industrial Estate TR16 4AX Redruth Unit 3 Jon Davey Road Cornwall England | England | British | |
OXFORD REFRIGERATION LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Mackenzie Way Swindon Village GL51 9TX Cheltenham 1 Manor Park Business Centre England | England | British | |
LB SUPPLIES LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Manor Park Business Centre Mackenzie Way GL51 9TX Cheltenham 1 Gloucestershire England | England | British | |
ASHGROVE ONE LIMITED | 17. Juni 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 1 New Road TQ5 8LZ Brixham Grosvenor House England | England | British | |
PENTWIN GROUP LIMITED | 28. Mai 2024 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Manor Park Business Centre Mackenzie Way Swindon Village GL51 9TX Cheltenham 1 Gloucestershire | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0