Lynne Margaret BAGLOW
Natürliche Person
Titel | Mrs |
---|---|
Vorname | Lynne |
Zweites Vornamen | Margaret |
Nachname | BAGLOW |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 11 |
Gesamt | 11 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. G. MEDIA RESOURCES LIMITED | 07. Sept. 2018 | 25. Aug. 2022 | Aktiv | Finance | Geschäftsführer | Corsham Mansion House Pickwick Road SN13 9BL Corsham The Stables Wiltshire England | England | British |
FADE OUT LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Aktiv | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire Uk | England | British |
LYNCH-STAUNTON COSMETICS HOLDINGS LIMITED | 01. Apr. 2017 | 16. Feb. 2018 | Aufgelöst | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire | England | British |
VIVALIS HOLDINGS LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Aufgelöst | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire Uk | England | British |
VIVALIS LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Aufgelöst | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire Uk | England | British |
PURPLE TREE SKINCARE LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Aufgelöst | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue Whitehorse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire U.K. | England | British |
TATTOO SKINCARE LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Aufgelöst | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire | England | British |
LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Aufgelöst | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire Uk | England | British |
VIVALIS BEAUTY LIMITED | 01. Apr. 2017 | 16. Feb. 2018 | Liquidation | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | England | British |
FINE FRAGRANCES AND COSMETICS LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Liquidation | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire Uk | England | British |
VIVALIS GROUP LIMITED | 27. Jan. 2017 | 16. Feb. 2018 | Liquidation | Finance And Operations Director | Geschäftsführer | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire U.K. | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0