• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Robert Firbank ASHTON

    Natürliche Person

    Titel
    VornameRobert
    Zweites VornamenFirbank
    NachnameASHTON
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv3
    Inaktiv0
    Zurückgetreten31
    Gesamt34

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    ACAR (REALISATIONS) LIMITED04. Dez. 1997LiquidationSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    RIETER-SCRAGG LIMITED31. Dez. 1992AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    RIETER-SCRAGG LIMITED31. Dez. 1992AktivGeschäftsführer
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish
    AUTONEUM GREAT BRITAIN LIMITED30. Okt. 199201. Juli 2016AktivGeschäftsführer
    Stanley Matthews Way
    Trentham Lakes South
    ST4 8GR Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish
    AUTONEUM GREAT BRITAIN LIMITED01. Juli 2016AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    HACKING ASHTON LLP09. Jan. 200401. Mai 2009AufgelöstMitglied der LLP
    The Gables
    Three Mile Lane, Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    England
    STAFFORDSHIRE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY LTD.05. Dez. 200505. Nov. 2008AktivGeschäftsführer
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish
    NORTH STAFFORDSHIRE LAW SOCIETY(THE)07. Sept. 200413. Sept. 2006AufgelöstGeschäftsführer
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish
    HAJCO SECRETARIES LIMITED05. Okt. 200413. Apr. 2006AufgelöstGeschäftsführer
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish
    HAJCO DIRECTORS LIMITED05. Okt. 200413. Apr. 2006AufgelöstGeschäftsführer
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish
    HAJCO DIRECTORS LIMITED22. Feb. 200013. Apr. 2006AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    HAJCO SECRETARIES LIMITED05. März 199913. Apr. 2006AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    PENNINE TRENT LIMITED22. Feb. 200010. Apr. 2000AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    PREACC LIMITED26. Nov. 199910. Feb. 2000AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    WORLDHQ LIMITED26. Nov. 199903. Feb. 2000AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    LAIDRITE CONSTRUCTION LIMITED16. Juni 199929. Juli 1999AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    LAIDRITE SURFACING CO LIMITED16. Juni 199929. Juli 1999AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    HAJCO 205 LIMITED22. Feb. 199911. Juni 1999AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    FREESTYLE UK LIMITED22. Feb. 199901. Juni 1999AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    AVISON YOUNG WORKPLACE LIMITED04. Jan. 199918. Feb. 1999AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    PROUDLEN (UK) LIMITED14. Apr. 199810. Dez. 1998AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    M.C. SHEET METAL LIMITED31. Dez. 199203. Apr. 1998AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    BAUMANN SPRINGS & PRESSINGS (UK) LIMITED01. Nov. 199201. Apr. 1998AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    HAJCO 199 LIMITED28. Nov. 199712. März 1998AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    OHIO MEDICAL INSTRUMENT COMPANY EUROPE LIMITED28. Nov. 199712. Feb. 1998AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    CASSANIE PUBLISHING SERVICES LIMITED28. Nov. 199715. Dez. 1997AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    LITTLE YOUTH LIMITED24. Juli 199622. Okt. 1997AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    CREATIVE THING LIMITED09. Jan. 199716. Juli 1997AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    SHELLEY FIBRE SANDWICH CONSTRUCTION SYSTEM LIMITED09. Jan. 199709. Juni 1997AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    BAUMANN SPRINGS & PRESSINGS (UK) LIMITED01. Nov. 199215. Apr. 1997AufgelöstGeschäftsführer
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish
    CASTLE TOOL HIRE LIMITED24. Juli 199631. Jan. 1997AktivSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    AVON EQUIPMENT LIMITED24. Juli 199605. Sept. 1996AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    ITC RESEARCH LTD12. Apr. 199601. Sept. 1996AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British
    FORSHAMMAR MINERALS LIMITED12. Apr. 199605. Juli 1996AufgelöstSekretär
    The Gables Three Mile Lane
    Keele
    ST5 5HH Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0